FOREVER BROADCASTING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FOREVER BROADCASTING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03844914 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FOREVER BROADCASTING LIMITED?
- Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione
Dove si trova FOREVER BROADCASTING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 London Bridge Street SE1 9GF London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FOREVER BROADCASTING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FOREVER BROADCASTING PLC | 20 set 1999 | 20 set 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FOREVER BROADCASTING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per FOREVER BROADCASTING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 giu 2020 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 5 pagine | AA | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 01 lug 2018 | 5 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Michael Charles Gill come amministratore in data 21 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2017 | 14 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Scott William Taunton il 02 mar 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Anthony David Tompkins come amministratore in data 30 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Norman Mckeown come amministratore in data 30 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2016 al 30 giu 2017 | 1 pagine | AA01 | ||
Cessazione della carica di Anthony Tompkins come segretario in data 30 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Christopher Charles Stoddart Longcroft come amministratore in data 30 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Scott William Taunton il 19 dic 2016 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor 401 Faraday Street, Birchwood Park Warrington WA3 6GA England a 1 London Bridge Street London SE1 9GF in data 02 dic 2016 | 1 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di John Mccann come amministratore in data 12 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di FOREVER BROADCASTING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILL, Michael Charles | Amministratore | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | United Kingdom | British | 123013340001 | |||||
| LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart | Amministratore | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | 163116880001 | |||||
| TAUNTON, Scott William | Amministratore | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 80505610007 | |||||
| DOWNEY, James Robinson | Segretario | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | 107097580001 | ||||||
| FRANCIS, Sharon Lesley | Segretario | 3 Primrose Close DL16 7YE Spennymoor County Durham | British | 72419260001 | ||||||
| JOSEPHS, John Irving | Segretario | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 3830990001 | ||||||
| SADLER, Keith John | Segretario | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||
| TOMPKINS, Anthony | Segretario | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | 165681280001 | |||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Segretario nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| BLEAKLEY, Tim James | Amministratore | 46 Gondar Gardens NW6 1HG London | United Kingdom | British | 153582240001 | |||||
| CASSIDY, Denis Patrick | Amministratore | 19 Ashburnham Close East Finchley N2 0NH London | England | British | 2425420001 | |||||
| DOBSON, Maurice John | Amministratore | 14 Haughton Terrace NE24 2HA Blyth Northumberland | United Kingdom | British | 47946730001 | |||||
| DOWNEY, James Robinson | Amministratore | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | United Kingdom | British | 107097580001 | |||||
| DUNNE, George Henry | Amministratore | 27 The Bridle Woodham Village DL5 4TH Newton Aycliffe County Durham | British | 72942820001 | ||||||
| JOSEPHS, John Irving | Amministratore | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 3830990001 | |||||
| KING, Stephen James | Amministratore | The Barn 4 Swallows Court Long Bennington NG23 5FD Newark Nottinghamshire | England | British | 72692220002 | |||||
| LAWRENCE, Eric Alexander | Amministratore | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | 4250810002 | ||||||
| MACHIN, Barrington Howard | Amministratore | Westfield Mill Lane Wetley Rocks ST9 0BN Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 2107970001 | |||||
| MACKENZIE, Ashley Calder | Amministratore | 6 Springshaw Close TN13 2QE Sevenoaks Kent | British | 59529980005 | ||||||
| MACKENZIE, Kelvin Calder | Amministratore | Christophers Lockstone Close KT13 8EF Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 141795340001 | |||||
| MCCANN, John | Amministratore | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | 75447990001 | |||||
| MCKEOWN, Norman | Amministratore | Ormeau Road BT7 1EB Belfast Havelock House Northern Ireland | Northern Ireland | British | 165664890001 | |||||
| ROBINSON, Kathleen Ellen | Amministratore | Tenter House NE47 0LB Hexham Northumberland | British | 3640550001 | ||||||
| SADLER, Keith John | Amministratore | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||
| SQUIRE, Giles | Amministratore | The Old Vicarage The Village NE65 9BL Morpeth Northumberland | England | British | 109514810001 | |||||
| TOMPKINS, Anthony David | Amministratore | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | 165684030001 | |||||
| WHITNEY, John Norton Braithwaite | Amministratore | The Long Barn Church Close Todber DT10 1JH Sturminster Newton Dorset | England | British | 91336950001 | |||||
| JL NOMINEES ONE LIMITED | Amministratore delegato nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FOREVER BROADCASTING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless Group Media (Gb) Limited | 06 apr 2016 | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
FOREVER BROADCASTING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 14 ott 2002 Consegnato il 22 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 set 2002 Consegnato il 02 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 dic 1999 Consegnato il 04 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0