RETEC INTERFACE LIMITED
Panoramica
Nome della società | RETEC INTERFACE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03856111 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RETEC INTERFACE LIMITED?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova RETEC INTERFACE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Two Snowhill B4 6GA Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RETEC INTERFACE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
RETEC (EUROPE) LIMITED | 08 ott 1999 | 08 ott 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RETEC INTERFACE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per RETEC INTERFACE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 22 pagine | 4.72 | ||||||||||
Domanda di insolvenza Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 ago 2016 | 19 pagine | 4.68 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario | 1 pagine | 4.40 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD a Two Snowhill Birmingham B4 6GA in data 23 dic 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 ago 2015 | 19 pagine | 4.68 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 29 ago 2014 | 16 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 1 pagine | 2.34B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 mar 2014 | 13 pagine | 2.24B | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 1 pagine | F2.18 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B | 7 pagine | 2.16B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 35 pagine | 2.17B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth Leicestershire LE17 5FB England* in data 21 ott 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Payne come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2012 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 10 pagine | MG01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Heaton come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2011 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Tittensor come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2010 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RETEC INTERFACE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWRYCH, Victor | Segretario | Somerset Road W13 9PB London 24 | British | 137519070001 | ||||||
DERBY, Graeme Robert | Amministratore | Snowhill B4 6GA Birmingham Two | England | British | Director | 58244300002 | ||||
MCKAY, Charles Richard Harvey | Amministratore | Snowhill B4 6GA Birmingham Two | United Kingdom | British | Accountant | 69581910001 | ||||
COLE, John | Segretario | 5 Baldock Road SG6 3LB Letchworth Hertfordshire | British | Director | 1446500002 | |||||
KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED | Segretario nominato | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004240001 | |||||||
COLE, John | Amministratore | Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5BE Lutterworth Leicestershire | England | British | Director | 1446500002 | ||||
ELLIS, Bryan John | Amministratore | Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5BE Lutterworth Leicestershire | England | British | Consultant | 3187020001 | ||||
HEATON, Timothy Sean | Amministratore | Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5FB Lutterworth Alma Park Leicestershire England | England | British | Sales & Marketing Director | 134561250001 | ||||
HUGHES, Nicholas David | Amministratore | 71 Old Gorse Way Mawsley NN14 1GJ Kettering Northamptonshire | England | British | Director | 115666100001 | ||||
INSKIP, Graham Austin | Amministratore | Lilac Cottage Colmworth Road, Little Staughton MK44 2BY Bedfordshire | England | British | Director | 171534390001 | ||||
IVORY, Brian Gammell, Sir | Amministratore | 12 Ann Street EH4 1PJ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Company Director | 107780003 | ||||
MAKULSKI, Jerzy Leon | Amministratore | The Grange Fallow End Pottersheath Road AL6 9ST Welwyn Hertfordshire | British | Sales Marketing Director | 50680300001 | |||||
O'GORMAN, Peter Joseph | Amministratore | 31 Old Chimney Road Upper Saddle River New Jersey 07458 Usa | American | Director | 66522060001 | |||||
PAYNE, Mark Richard | Amministratore | Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5FB Lutterworth Alma Park Leicestershire England | England | British | Accountant | 125436870001 | ||||
THOMAS, Glyn Collen | Amministratore | 12 Westfield Road HP9 1EF Beaconsfield Buckinghamshire | British | Director | 4170780002 | |||||
TITTENSOR, Neil Martin | Amministratore | Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5FB Lutterworth Alma Park Leicestershire England | England | British | Operations Director | 110130160002 | ||||
WILLIAMS, Andrea Jane | Amministratore | Ridge Hall High Street MK43 0TS Ridgmont Bedfordshire | British | Director | 46650990001 | |||||
KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED | Amministratore delegato nominato | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004230001 |
RETEC INTERFACE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 08 feb 2013 Consegnato il 16 feb 2013 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the guarantors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 24 dic 2007 Consegnato il 29 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 42" panasonic plasma amount used 42 42" plasma speakers (pair) amount used 42 unicol plasma bracket amount used 42 for further details of the goods charged please refer to form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 03 set 2007 Consegnato il 21 set 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Computer hardware and software, 42' panasonic plasma, 42' plasma speakers (pair), unicol plasma bracket, for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 19 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The computer hardware and software being 12 rics software 60 plasma bracket 22 vac form shroud and bracket (for details of further equipment charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 28 feb 2007 Consegnato il 15 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Computer hardware and software, rics software (14), plasma bracket (50), vac form shroud and bracket (14), for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 21 dic 2006 Consegnato il 05 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Computer hardware and software. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 12 ott 2006 Consegnato il 28 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Computer hardware and software. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 30 ago 2006 Consegnato il 07 set 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Various equipment described in schedule attached to the legal mortgage dated 30TH august 2006. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 17 ago 2006 Consegnato il 22 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 1 computer hardware and software. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 15 giu 2006 Consegnato il 17 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Computer software and hardware as described in schedule of goods contained within the chattel mortgage dated 15TH june 2006. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 15 giu 2006 Consegnato il 17 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Computer software and hardware as described in schedule of goods contained within the chattel mortgage dated 15TH june 2006. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 ago 2004 Consegnato il 28 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 gen 2002 Consegnato il 26 gen 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 ago 2000 Consegnato il 30 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,281.25 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All monies from time to time in the rent deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 14 dic 1999 Consegnato il 23 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
RETEC INTERFACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0