RETEC INTERFACE LIMITED

RETEC INTERFACE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRETEC INTERFACE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03856111
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RETEC INTERFACE LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova RETEC INTERFACE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Two
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RETEC INTERFACE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RETEC (EUROPE) LIMITED08 ott 199908 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di RETEC INTERFACE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per RETEC INTERFACE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagine4.72

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 ago 2016

    19 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Indirizzo della sede legale modificato da 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD a Two Snowhill Birmingham B4 6GA in data 23 dic 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 ago 2015

    19 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 29 ago 2014

    16 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 mar 2014

    13 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    7 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth Leicestershire LE17 5FB England* in data 21 ott 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Mark Payne come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    15 pagineAA

    legacy

    10 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 08 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2012

    Stato del capitale al 30 ott 2012

    • Capitale: GBP 2,320.9
    SH01

    Cessazione della carica di Timothy Heaton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Neil Tittensor come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RETEC INTERFACE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAWRYCH, Victor
    Somerset Road
    W13 9PB London
    24
    Segretario
    Somerset Road
    W13 9PB London
    24
    British137519070001
    DERBY, Graeme Robert
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    Amministratore
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    EnglandBritishDirector58244300002
    MCKAY, Charles Richard Harvey
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    Amministratore
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    United KingdomBritishAccountant69581910001
    COLE, John
    5 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    BritishDirector1446500002
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Segretario nominato
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    COLE, John
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5BE Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5BE Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector1446500002
    ELLIS, Bryan John
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5BE Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5BE Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandBritishConsultant3187020001
    HEATON, Timothy Sean
    Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Alma Park
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Alma Park
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishSales & Marketing Director134561250001
    HUGHES, Nicholas David
    71 Old Gorse Way
    Mawsley
    NN14 1GJ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    71 Old Gorse Way
    Mawsley
    NN14 1GJ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector115666100001
    INSKIP, Graham Austin
    Lilac Cottage
    Colmworth Road, Little Staughton
    MK44 2BY Bedfordshire
    Amministratore
    Lilac Cottage
    Colmworth Road, Little Staughton
    MK44 2BY Bedfordshire
    EnglandBritishDirector171534390001
    IVORY, Brian Gammell, Sir
    12 Ann Street
    EH4 1PJ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    12 Ann Street
    EH4 1PJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishCompany Director107780003
    MAKULSKI, Jerzy Leon
    The Grange Fallow End
    Pottersheath Road
    AL6 9ST Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Grange Fallow End
    Pottersheath Road
    AL6 9ST Welwyn
    Hertfordshire
    BritishSales Marketing Director50680300001
    O'GORMAN, Peter Joseph
    31 Old Chimney Road
    Upper Saddle River
    New Jersey 07458
    Usa
    Amministratore
    31 Old Chimney Road
    Upper Saddle River
    New Jersey 07458
    Usa
    AmericanDirector66522060001
    PAYNE, Mark Richard
    Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Alma Park
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Alma Park
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishAccountant125436870001
    THOMAS, Glyn Collen
    12 Westfield Road
    HP9 1EF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    12 Westfield Road
    HP9 1EF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector4170780002
    TITTENSOR, Neil Martin
    Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Alma Park
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Alma Park
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishOperations Director110130160002
    WILLIAMS, Andrea Jane
    Ridge Hall
    High Street
    MK43 0TS Ridgmont
    Bedfordshire
    Amministratore
    Ridge Hall
    High Street
    MK43 0TS Ridgmont
    Bedfordshire
    BritishDirector46650990001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    RETEC INTERFACE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 feb 2013
    Consegnato il 16 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the guarantors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meadowside Leasing Limited
    Transazioni
    • 16 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 24 dic 2007
    Consegnato il 29 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    42" panasonic plasma amount used 42 42" plasma speakers (pair) amount used 42 unicol plasma bracket amount used 42 for further details of the goods charged please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 set 2007
    Consegnato il 21 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Computer hardware and software, 42' panasonic plasma, 42' plasma speakers (pair), unicol plasma bracket, for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The computer hardware and software being 12 rics software 60 plasma bracket 22 vac form shroud and bracket (for details of further equipment charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 15 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Computer hardware and software, rics software (14), plasma bracket (50), vac form shroud and bracket (14), for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 05 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Computer hardware and software.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 12 ott 2006
    Consegnato il 28 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Computer hardware and software.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 30 ago 2006
    Consegnato il 07 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various equipment described in schedule attached to the legal mortgage dated 30TH august 2006.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 ago 2006
    Consegnato il 22 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1 computer hardware and software.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 15 giu 2006
    Consegnato il 17 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Computer software and hardware as described in schedule of goods contained within the chattel mortgage dated 15TH june 2006.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 15 giu 2006
    Consegnato il 17 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Computer software and hardware as described in schedule of goods contained within the chattel mortgage dated 15TH june 2006.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 ago 2004
    Consegnato il 28 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Elite Strategies PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 gen 2002
    Consegnato il 26 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 ago 2000
    Consegnato il 30 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,281.25 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies from time to time in the rent deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Wheatley Developments Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 dic 1999
    Consegnato il 23 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RETEC INTERFACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 ago 2014Fine dell'amministrazione
    19 set 2013Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Edward Terence Kerr
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    2
    DataTipo
    25 lug 2017Data di scioglimento
    29 ago 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Liquidatore proposto
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Edward Terence Kerr
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Liquidatore proposto
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Ian James Gould
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0