LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED

LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03858489
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAC NO.193 LIMITED13 ott 199913 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    19 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref:Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    2 pagineAD03

    Indirizzo della sede legale modificato da Number One Great Exhibition Way Kirkstall Forge Leeds LS5 3BF United Kingdom a 1 City Square Leeds LS1 2AL in data 20 feb 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 gen 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 gen 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Andrew Kirby come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dominic Gerard Patrick Moran come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Connor come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Munro Hughes come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Robert Gibson come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Peter Buchan come amministratore in data 19 gen 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    18 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Leasedrive Velo Holdings Limited come persona con controllo significativo il 20 nov 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Anglia House Holly Park Mills Calverley Leeds LS28 5QS a Number One Great Exhibition Way Kirkstall Forge Leeds LS5 3BF in data 20 nov 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Patrick James Rawnsley come segretario in data 17 lug 2017

    2 pagineAP03

    Iscrizione dell'ipoteca 038584890006, creata il 29 giu 2017

    25 pagineMR01

    Cessazione della carica di Sarah Elizabeth Jones come segretario in data 30 giu 2017

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RAWNSLEY, Patrick James
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Segretario
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    236009760001
    BUTLER, Robert Alan
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    United KingdomBritish168472630001
    PHILLIPS, Mark Trevor, Mr.
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    EnglandBritish60778940002
    BIRD, David Alan
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Segretario
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    British89738470001
    JONES, Sarah Elizabeth
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Segretario
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    186217210001
    PAY, Graham Clive Malcolm
    59 Cheylesmore Drive
    GU16 5BN Camberley
    Surrey
    Segretario
    59 Cheylesmore Drive
    GU16 5BN Camberley
    Surrey
    British55336530001
    ABBEY NOMINEES LIMITED
    Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Segretario nominato
    Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    900019330001
    BIRD, David Alan
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    United KingdomBritish89738470001
    BUCHAN, Timothy Peter
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    EnglandBritish109172820004
    CONNOR, Mark
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    EnglandBritish166528620002
    FARRELL, Sean Patrick
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    United KingdomBritish186202970001
    FLEMING, Paul Scott
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish150909200004
    FOULDS, David Michael
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    EnglandBritish122016350001
    GIBSON, Ian Robert
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish204166970001
    GRAHAM, Roderick Neil
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    EnglandBritish51466570002
    HOWICK, Joseph Anthony
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    United Kingdom
    EnglandBritish210501330001
    HUGHES, Ian Munro
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    United KingdomBritish186347480001
    JOHNSTON, Anthony Maurice
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    Amministratore
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    EnglandBritish91243020001
    KIRBY, Andrew
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    United KingdomBritish183402450002
    MORAN, Dominic Gerard Patrick
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Exhibition Way
    LS5 3BF Kirkstall Forge
    Number One
    Leeds
    United Kingdom
    United KingdomBritish176868040001
    PARTRIDGE, Roger Graham
    Crowthorne House
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Crowthorne House
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Berkshire
    BerkshireBritish84959730003
    PAY, Graham Clive Malcolm
    59 Cheylesmore Drive
    GU16 5BN Camberley
    Surrey
    Amministratore
    59 Cheylesmore Drive
    GU16 5BN Camberley
    Surrey
    British55336530001
    ROSE, Claudia Giuliana Maria
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    EnglandBritish196764720001
    SNEATH, Brian Richard
    Yardfield House
    Church Lane, Worplesdon
    GU3 3RU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Yardfield House
    Church Lane, Worplesdon
    GU3 3RU Guildford
    Surrey
    British68319930001
    THOMPSON, Matthew Longstreth
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Park Mills
    Calverley
    LS28 5QS Leeds
    Anglia House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish204204250001
    WHITROW, Robert William Guy
    Crowthorne House
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Crowthorne House
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish83349560001
    ABBEY DIRECTORS LIMITED
    Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Amministratore delegato nominato
    Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    900019320001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great Exhibition Way
    Kirkstall Forge
    LS5 3BF Leeds
    Number One
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Exhibition Way
    Kirkstall Forge
    LS5 3BF Leeds
    Number One
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6009746
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 giu 2017
    Consegnato il 18 lug 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 18 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 feb 2014
    Consegnato il 06 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2011
    Consegnato il 07 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander Asset Finance PLC (Creditor)
    Transazioni
    • 07 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 ago 2008
    Consegnato il 05 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H interest in the property k/a office suites 1 and 2 first floor guildgate house high street crowthorne berkshire t/no BK261879,l/h interest in the property k/a regal house station road marlow t/no BM245030,l/h interest in the property k/a part second floor crowthorne house nine mile ride crowthorne t/no BK394247 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 05 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2018Inizio della liquidazione
    09 mag 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0