LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03858489 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 City Square LS1 2AL Leeds |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GAC NO.193 LIMITED | 13 ott 1999 | 13 ott 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 19 pagine | LIQ13 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref:Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Number One Great Exhibition Way Kirkstall Forge Leeds LS5 3BF United Kingdom a 1 City Square Leeds LS1 2AL in data 20 feb 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 gen 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Kirby come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Gerard Patrick Moran come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Connor come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Munro Hughes come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Robert Gibson come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Peter Buchan come amministratore in data 19 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Leasedrive Velo Holdings Limited come persona con controllo significativo il 20 nov 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Anglia House Holly Park Mills Calverley Leeds LS28 5QS a Number One Great Exhibition Way Kirkstall Forge Leeds LS5 3BF in data 20 nov 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Patrick James Rawnsley come segretario in data 17 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 038584890006, creata il 29 giu 2017 | 25 pagine | MR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Elizabeth Jones come segretario in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWNSLEY, Patrick James | Segretario | City Square LS1 2AL Leeds 1 | 236009760001 | |||||||
| BUTLER, Robert Alan | Amministratore | City Square LS1 2AL Leeds 1 | United Kingdom | British | 168472630001 | |||||
| PHILLIPS, Mark Trevor, Mr. | Amministratore | City Square LS1 2AL Leeds 1 | England | British | 60778940002 | |||||
| BIRD, David Alan | Segretario | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | British | 89738470001 | ||||||
| JONES, Sarah Elizabeth | Segretario | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | 186217210001 | |||||||
| PAY, Graham Clive Malcolm | Segretario | 59 Cheylesmore Drive GU16 5BN Camberley Surrey | British | 55336530001 | ||||||
| ABBEY NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 900019330001 | |||||||
| BIRD, David Alan | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | United Kingdom | British | 89738470001 | |||||
| BUCHAN, Timothy Peter | Amministratore | Great Exhibition Way LS5 3BF Kirkstall Forge Number One Leeds United Kingdom | England | British | 109172820004 | |||||
| CONNOR, Mark | Amministratore | Great Exhibition Way LS5 3BF Kirkstall Forge Number One Leeds United Kingdom | England | British | 166528620002 | |||||
| FARRELL, Sean Patrick | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | United Kingdom | British | 186202970001 | |||||
| FLEMING, Paul Scott | Amministratore | Nine Mile Ride RG40 3GA Wokingham Crowthorne House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 150909200004 | |||||
| FOULDS, David Michael | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | England | British | 122016350001 | |||||
| GIBSON, Ian Robert | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 204166970001 | |||||
| GRAHAM, Roderick Neil | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | England | British | 51466570002 | |||||
| HOWICK, Joseph Anthony | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House United Kingdom | England | British | 210501330001 | |||||
| HUGHES, Ian Munro | Amministratore | Great Exhibition Way LS5 3BF Kirkstall Forge Number One Leeds United Kingdom | United Kingdom | British | 186347480001 | |||||
| JOHNSTON, Anthony Maurice | Amministratore | 14 Agars Place Datchet SL3 9AH Berkshire | England | British | 91243020001 | |||||
| KIRBY, Andrew | Amministratore | Great Exhibition Way LS5 3BF Kirkstall Forge Number One Leeds United Kingdom | United Kingdom | British | 183402450002 | |||||
| MORAN, Dominic Gerard Patrick | Amministratore | Great Exhibition Way LS5 3BF Kirkstall Forge Number One Leeds United Kingdom | United Kingdom | British | 176868040001 | |||||
| PARTRIDGE, Roger Graham | Amministratore | Crowthorne House Nine Mile Ride RG40 3GA Wokingham Berkshire | Berkshire | British | 84959730003 | |||||
| PAY, Graham Clive Malcolm | Amministratore | 59 Cheylesmore Drive GU16 5BN Camberley Surrey | British | 55336530001 | ||||||
| ROSE, Claudia Giuliana Maria | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House | England | British | 196764720001 | |||||
| SNEATH, Brian Richard | Amministratore | Yardfield House Church Lane, Worplesdon GU3 3RU Guildford Surrey | British | 68319930001 | ||||||
| THOMPSON, Matthew Longstreth | Amministratore | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 204204250001 | |||||
| WHITROW, Robert William Guy | Amministratore | Crowthorne House Nine Mile Ride RG40 3GA Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 83349560001 | |||||
| ABBEY DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 900019320001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasedrive Velo Holdings Limited | 06 apr 2016 | Great Exhibition Way Kirkstall Forge LS5 3BF Leeds Number One United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 29 giu 2017 Consegnato il 18 lug 2017 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 28 feb 2014 Consegnato il 06 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 gen 2011 Consegnato il 07 gen 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 ago 2008 Consegnato il 05 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H interest in the property k/a office suites 1 and 2 first floor guildgate house high street crowthorne berkshire t/no BK261879,l/h interest in the property k/a regal house station road marlow t/no BM245030,l/h interest in the property k/a part second floor crowthorne house nine mile ride crowthorne t/no BK394247 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 dic 2006 Consegnato il 22 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 mag 2003 Consegnato il 10 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LEASEDRIVE HOLDINGS (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0