CISION UK HOLDINGS LIMITED

CISION UK HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCISION UK HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03858850
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MEDIA INTELLIGENCE UK LTD18 gen 200018 gen 2000
    LINKSTILL LIMITED14 ott 199914 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Soddisfazione dell'onere 038588500006 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 038588500005 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 038588500004 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 038588500003 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 ott 2020

    6 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Churchill Place London E14 5HU England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 01 nov 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 ott 2019

    LRESSP

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 set 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 25/09/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 31 gen 2019

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    17 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 038588500006, creata il 12 gen 2018

    64 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Cision Ltd come persona con controllo significativo il 29 giu 2017

    1 paginePSC02

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 038588500005, creata il 18 set 2017

    64 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AKEROYD, Kevin
    East Randolph Street
    Suite 700
    Chicago
    130
    Illinois 60601
    United States
    Amministratore
    East Randolph Street
    Suite 700
    Chicago
    130
    Illinois 60601
    United States
    United StatesAmerican213466620001
    PEARLSTEIN, Jacob
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United StatesAmerican195105580001
    CULLEN, Andrew Arthur
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    Segretario
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    British74625030001
    FAUTLEY, Mark Stephen
    25 Barge Walk
    SE10 0FN London
    Flat 132
    England
    Segretario
    25 Barge Walk
    SE10 0FN London
    Flat 132
    England
    188160940001
    HEAD, Andrew James
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    British115498340001
    JANSSON, Gote Jan-Erik
    Skogviksvagen 49
    Danderyd
    Se 18239
    Sweden
    Segretario
    Skogviksvagen 49
    Danderyd
    Se 18239
    Sweden
    Swedish68201060002
    KENT, Samantha
    3 White Hill
    Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    3 White Hill
    Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    British118954610001
    KIMBER, Rachel Natasha
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Segretario
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    146567970001
    MACKENZIE, Cameron
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Segretario
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British49484390001
    RITCHIE, Thomas David
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Segretario
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    177427270001
    WHEELER, Kevin
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Segretario
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    181952120001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLANDY, Yann
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    SwedenFrench161278830001
    BODIE, Giselle Lillian
    High Orchard
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    High Orchard
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish65078960002
    BRUCE-MORGAN, Torsten Morris Tomas
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    EnglandBritish93435540002
    CULLEN, Andrew Arthur
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    British74625030001
    FORSBERG, Erik
    Vikingav 10 B
    Djorsholm
    18263
    Sweden
    Amministratore
    Vikingav 10 B
    Djorsholm
    18263
    Sweden
    SwedenSwedish138693950001
    GRANAT, Peter Wruble
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    Amministratore
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    Illinois, UsaBritish309583160001
    GRANAT, Peter Wruble
    King Henrys Road
    Primrose Hill
    NW3 3QP London
    Flat 5, 5
    Amministratore
    King Henrys Road
    Primrose Hill
    NW3 3QP London
    Flat 5, 5
    United KingdomUnited States138694710001
    HANSSON, Nina Charlotte Vithlani
    Linnegatan
    PO BOX 24194
    104 51 Stockholm
    87a
    Sweden
    Amministratore
    Linnegatan
    PO BOX 24194
    104 51 Stockholm
    87a
    Sweden
    SwedenSwedish182693150001
    HEAD, Andrew James
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    British115498340001
    HIGGINS, Michael Andrew
    Buttonwood
    Hain Walk
    TR26 2AF St Ives
    Cornwall
    Amministratore
    Buttonwood
    Hain Walk
    TR26 2AF St Ives
    Cornwall
    EnglandBritish116898590001
    JANSSON, Gote Jan-Erik
    Skogviksvagen 49
    Danderyd
    Se 18239
    Sweden
    Amministratore
    Skogviksvagen 49
    Danderyd
    Se 18239
    Sweden
    Swedish68201060002
    KELLY, Leslie George Edwin
    169 Priests Lane
    CM15 8LF Shenfield
    Essex
    Amministratore
    169 Priests Lane
    CM15 8LF Shenfield
    Essex
    British76315400002
    KENT, Samantha Jane
    Woodcroft
    3 White Hill Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodcroft
    3 White Hill Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish181522870001
    KIMBER, Rachel Natasha
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    United KingdomBritish151204940001
    LENGE, Jens-Peter
    164 Prince George Avenue
    N14 4TB London
    Amministratore
    164 Prince George Avenue
    N14 4TB London
    Danish69151650001
    LUNDMARK, Anders
    Nasvagen 18
    Sollentuna Se-19271
    Sweden
    Amministratore
    Nasvagen 18
    Sollentuna Se-19271
    Sweden
    Swedish98495900001
    MACKENZIE, Cameron
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish49484390001
    MUNIER, Marc Andrew James
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    EnglandBritish135852000002
    PALFREEMAN, Neil
    White Cottage Windsor Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DZ Great Missenden
    Bucks
    Amministratore
    White Cottage Windsor Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DZ Great Missenden
    Bucks
    EnglandBritish33210210001
    RITCHIE, Thomas
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    United KingdomBritish168336560001
    RUDEBJER BLOMQVIST, Majken Gunilla
    Bjorknagsstigen 10
    Se181 64 Lidingo
    Sweden
    Amministratore
    Bjorknagsstigen 10
    Se181 64 Lidingo
    Sweden
    Swedish117723880001
    STRAND, Hans Ewert
    Storkvagen 14
    Sollentuna
    19255
    Sweden
    Amministratore
    Storkvagen 14
    Sollentuna
    19255
    Sweden
    Swedish68201130002
    ULBERSTAD, Karin
    Furusundseatan 9
    FOREIGN Stockholm
    11537
    Sweden
    Amministratore
    Furusundseatan 9
    FOREIGN Stockholm
    11537
    Sweden
    Swedish67662200001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CISION UK HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cision Ltd
    Cayman Corporate Centre
    27 Hospital Road
    Georgetown
    Walkers Corporate Ltd
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    29 giu 2017
    Cayman Corporate Centre
    27 Hospital Road
    Georgetown
    Walkers Corporate Ltd
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    No
    Forma giuridicaLimited
    Autorità legaleCayman Islands Law
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    28-42 Anner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    06 apr 2016
    28-42 Anner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09062485
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CISION UK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 gen 2018
    Consegnato il 25 gen 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3(h) of the instrument, the company charged by way of first fixed charge all its present and future right, title and interest in and to all material intellectual property. For further details, please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as the Security Trustee
    Transazioni
    • 25 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 set 2017
    Consegnato il 28 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3(h) of the instrument, the company charged by way of first fixed charge all its present and future right, title and interest in and to all material intellectual property. For further details, please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as the Security Trustee
    Transazioni
    • 28 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2016
    Consegnato il 29 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3 of the debenture, the company has charged by way of fixed charge all its present and future material intellectual property and all related rights. For further details, please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 29 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2016
    Consegnato il 28 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3 of the debenture, the company has charged by way of first fixed charge all its present and future material intellectual property and all related rights. For further details, please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2014
    Consegnato il 13 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jefferies Finance Llc as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2014
    Consegnato il 13 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jefferies Finance Llc as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CISION UK HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ott 2019Inizio della liquidazione
    28 nov 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0