BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED

BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBASINGSTOKE OBSERVER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03861912
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED?

    • (2212) /
    • (2213) /

    Dove si trova BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRI MEDIA PUBLISHING LIMITED18 gen 200018 gen 2000
    MINICHARGE LIMITED20 ott 199920 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2012

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2011

    11 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Cessazione della carica di James Cowper Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 set 2010

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Phoenix House Bartholomew Street Newbury Berkshire RG14 5QA United Kingdom in data 27 ago 2010

    2 pagineAD01

    legacy

    5 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2009

    Stato del capitale al 26 ott 2009

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per James Cowper Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Howard Taylor il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2008

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2007

    10 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2006

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    6 pagine395

    Chi sono gli amministratori di BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Howard
    23 Park Lane
    Tilehurst
    RG31 5DW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    23 Park Lane
    Tilehurst
    RG31 5DW Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73139270001
    EUSTACE, Timothy
    7 Gardiner Close
    OX14 3YA Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    7 Gardiner Close
    OX14 3YA Abingdon
    Oxfordshire
    British5555740001
    FUSSEY, Stephen Frederick
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    Segretario
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    British53550330001
    HALL, Susan Jayne
    2 Lees Farm Barn
    Pyrford Road Pyrford
    GU22 8UE Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Lees Farm Barn
    Pyrford Road Pyrford
    GU22 8UE Woking
    Surrey
    British81722340001
    POMROY, Nicholas Stephen
    8 Heath End Road
    Baughurst
    RG26 5LX Tadley
    Hampshire
    Segretario
    8 Heath End Road
    Baughurst
    RG26 5LX Tadley
    Hampshire
    British50915860001
    JAMES COWPER LIMITED
    Bartholomew Street
    RG14 5QA Newbury
    Phoenix House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Bartholomew Street
    RG14 5QA Newbury
    Phoenix House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02096054
    129277380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CHAPMAN, Kimberlee Ann
    29 Queens Road
    Caversham
    RG4 8DN Reading
    Berkshire
    Amministratore
    29 Queens Road
    Caversham
    RG4 8DN Reading
    Berkshire
    British68903800001
    CHESTER, Brian Robert
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish68831100001
    CRAIG, Andrew Timms
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    Amministratore
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    EnglandBritish34714840003
    FUSSEY, Stephen Frederick
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    British53550330001
    HOLMES, Ronald
    Ivy House
    Mapledurwell
    RG25 2LG Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Ivy House
    Mapledurwell
    RG25 2LG Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish26355080001
    HOYLE, Geoffrey Robert
    Ferndene
    Tanners Lane, Chalkhouse Green
    RG4 9AD Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Ferndene
    Tanners Lane, Chalkhouse Green
    RG4 9AD Reading
    Berkshire
    British69104890001
    ROBERTSON, John
    8 The Chase
    Donnington
    RG14 3AQ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 The Chase
    Donnington
    RG14 3AQ Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish4907930002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 gen 2010
    Consegnato il 15 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • GENER8 Finance Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2008
    Consegnato il 16 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge and legal mortgage all f/h and l/h property and fixed charge all estates or interests in any f/h or l/h property and all fixed plant and machinery and fixtures (including trade fixtures) in or attached to such property from time to time all stocks shares bonds and other securities all goodwill unpaid and/or uncalled capital all the intellectual property all the specified debts and all the other debts and floating charge the floating assets.
    Persone aventi diritto
    • Cattles Invoice Finance (Oxford) Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 05 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 feb 2003
    Consegnato il 10 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 feb 2003
    Consegnato il 03 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Intrinsic Value PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2000
    Consegnato il 20 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transazioni
    • 20 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BASINGSTOKE OBSERVER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 feb 2014Data di scioglimento
    09 set 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Arthur Kirkpatrick
    Wilkins Kennedy Llp 92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Praticante
    Wilkins Kennedy Llp 92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Keith Aleric Stevens
    Wilkins Kennedy
    Gladstone House
    TW20 9HY 77/79 High Street
    Egham
    Praticante
    Wilkins Kennedy
    Gladstone House
    TW20 9HY 77/79 High Street
    Egham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0