GORDON'S CHEMIST LIMITED

GORDON'S CHEMIST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGORDON'S CHEMIST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03865851
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEADINGTALK LIMITED26 ott 199926 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di Mark Francis Muller come amministratore in data 24 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Paul Wass come amministratore in data 24 giu 2016

    2 pagineAP01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 giu 2016

    Stato del capitale al 07 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2015

    Stato del capitale al 28 ott 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr Andrew Richard Thompson come segretario in data 02 ott 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew Richard Thompson come amministratore in data 02 ott 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Charles Geoffrey Foster come amministratore in data 02 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Charles Geoffrey Foster come segretario in data 02 ott 2015

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2015 al 31 ago 2015

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2014

    Stato del capitale al 04 nov 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2013

    Stato del capitale al 04 nov 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Christopher Giles come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THOMPSON, Andrew Richard
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    Segretario
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    201554790001
    THOMPSON, Andrew Richard
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    EnglandBritish156945340001
    WASS, Jonathan Paul
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    England
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    England
    EnglandBritish209546930001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Segretario
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150401600001
    GORDON, Joanne Helen
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    British67149540002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Segretario
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    British63620010002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    AYLWARD, Christopher David
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Amministratore
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish59741430002
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    GORDON, Joanne Helen
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    British67149540002
    GORDON, Richard Michael
    19 Creskeld Drive
    LS19 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    19 Creskeld Drive
    LS19 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish67149480002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Amministratore
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MCCLINGTOCK, Jonathan Philip
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British124559980001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Amministratore
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish63620010002
    PATEL, Anant Vinod
    264 Burley Road
    LS4 2NY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    264 Burley Road
    LS4 2NY Leeds
    West Yorkshire
    British126533340001
    PILSBURY, Roger Graham
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    Amministratore
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    United KingdomBritish181627090001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    GORDON'S CHEMIST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 ago 2007
    Consegnato il 08 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge the undertaking and all property and assets including l/h properties k/a 7 quarry hill oulton leeds west yorkshire, 49 selby road leeds west yorkshire, rothwell health centre stonebridge lane rothwell leeds west yorkshire and 91 moresdale lane leeds west yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 08 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ago 2007
    Consegnato il 03 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stonebrig lane leeds,91 moorsdale lane leeds,7 quarry hill leeds,49 selby road leeds and all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on such property and or the proceeds of sale thereof a floating equitable charge on all future f/h and l/h property a fixed charge on the goodwill and uncalled capital all book and other debts floating charge on the undertaking and all property and assets of the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited and Barclay Pharmaceutical Limited
    Transazioni
    • 03 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 20 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 49 selby road leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 06 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as 7 quarry hill oulton leeds west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 06 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property forming the pharmacy at rothwell health centre stone brig lane rothwell leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 08 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 08 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a 91 moredale lane leeds (k/a chemist shop seacroft south one stop centre foundry lane leeds west yorkshire t/n WYK670268. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 08 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a 49 selby road leeds west yorkshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 apr 2000
    Consegnato il 29 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0