RUFFLETTE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRUFFLETTE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03868897
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RUFFLETTE LIMITED?

    • Tessitura di tessili (13200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova RUFFLETTE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RUFFLETTE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BANDEX NARROW TEXTILES LIMITED26 ott 199926 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di RUFFLETTE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RUFFLETTE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RUFFLETTE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 29 giu 2015

    16 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 gen 2015

    18 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    36 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Duke Street Mill Duke Street Rochdale Lancashire OL12 0LW England in data 22 lug 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 038688970007 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 038688970009

    15 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 038688970010

    20 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sharston Road Wythenshane Manchester M22 4TH in data 13 mar 2014

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 038688970008

    59 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 21 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2013

    Stato del capitale al 21 nov 2013

    • Capitale: EUR 1,085,000
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 038688970007

    5 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Martin Grubener come amministratore in data 20 dic 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andreas Geiger come amministratore in data 20 dic 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    19 pagineAA

    Nomina di Mr. Martin Grubener come amministratore in data 18 ago 2011

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di RUFFLETTE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAWSON, Philip Andrew
    45 Higher Dunscar
    Egerton
    BL7 9TF Bolton
    Segretario
    45 Higher Dunscar
    Egerton
    BL7 9TF Bolton
    BritishTextiles90661350001
    DAWSON, Philip Andrew
    45 Higher Dunscar
    Egerton
    BL7 9TF Bolton
    Amministratore
    45 Higher Dunscar
    Egerton
    BL7 9TF Bolton
    EnglandBritishManaging Director90661350001
    BARLEY, Michael Desmond Tennyson
    61 Fowlmere Road
    Heydon
    SG8 8PZ Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    61 Fowlmere Road
    Heydon
    SG8 8PZ Royston
    Hertfordshire
    British41224120001
    CLOUGH, Stephen John
    Cransley
    East Downs Road, Bowdon
    WA14 2LQ Altrincham
    Segretario
    Cransley
    East Downs Road, Bowdon
    WA14 2LQ Altrincham
    BritishChartered Accountant158703520001
    MCCULLAGH, John Francis
    2 Neville Court
    35 Weir Road
    SW12 0NU London
    Segretario
    2 Neville Court
    35 Weir Road
    SW12 0NU London
    British78531890001
    OKSAKOWSKI, Udo Georges
    Zollgasse 15
    Dornbirn A-6850
    FOREIGN Austria
    Segretario
    Zollgasse 15
    Dornbirn A-6850
    FOREIGN Austria
    AustrianBusiness Man67144830001
    RYDE, Mark Heselgrase
    22 Heatherfield Road
    Marsh
    HD1 4QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    22 Heatherfield Road
    Marsh
    HD1 4QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAccountant77792730001
    BOYLE, Ross Stanley
    572 London Road
    Davenham
    CW9 8LR Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    572 London Road
    Davenham
    CW9 8LR Northwich
    Cheshire
    BritishDirector89387270001
    CHUCK, Keble Rhys
    2 Leonard Cheshire Close
    DE75 7PB Heanor
    Derbyshire
    Amministratore
    2 Leonard Cheshire Close
    DE75 7PB Heanor
    Derbyshire
    BritishGeneral Manager78816770001
    CLOUGH, Stephen John
    Cransley
    East Downs Road, Bowdon
    WA14 2LQ Altrincham
    Amministratore
    Cransley
    East Downs Road, Bowdon
    WA14 2LQ Altrincham
    United KingdomBritishChartered Accountant158703520001
    GALLAGHER, Colin Nicholas
    Five Gables
    6 Church Lane
    HD4 7DB Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Five Gables
    6 Church Lane
    HD4 7DB Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector27747130002
    GEIGER, Andreas
    Bahnhofstrasse 28
    6820 Frastanz
    Austria
    Amministratore
    Bahnhofstrasse 28
    6820 Frastanz
    Austria
    AustriaAustrianDirector138695800001
    GRUBENER, Martin, Mr.
    Sharston Road
    Wythenshane
    M22 4TH Manchester
    Amministratore
    Sharston Road
    Wythenshane
    M22 4TH Manchester
    AustriaGermanDirector163400760001
    LAND, Peter Allan
    39 York Close
    Market Bosworth
    CV13 0ND Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    39 York Close
    Market Bosworth
    CV13 0ND Nuneaton
    Warwickshire
    BritishManaging Director8548980001
    MCGIBBON, Stephen Phillip
    5 Oakdene Crescent
    Ley Hey Park Marple
    SK6 6NZ Stockport
    Greater Manchester
    Amministratore
    5 Oakdene Crescent
    Ley Hey Park Marple
    SK6 6NZ Stockport
    Greater Manchester
    United KingdomBritishManaging Director78816740002
    MILLINGTON, David Nicholas
    16 Poplar Street
    SK4 3DG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    16 Poplar Street
    SK4 3DG Stockport
    Cheshire
    BritishSystems Director82310300001
    OKSAKOWSKI, Ingrid
    Schanzweg 16
    Feldkirch A-6800
    FOREIGN Austria
    Amministratore
    Schanzweg 16
    Feldkirch A-6800
    FOREIGN Austria
    AustrianBusiness Woman67144820001
    OKSAKOWSKI, Udo Georges
    Zollgasse 15
    Dornbirn A-6850
    FOREIGN Austria
    Amministratore
    Zollgasse 15
    Dornbirn A-6850
    FOREIGN Austria
    AustrianDirector67144830001
    OXER, Rosemary
    The Old Dairy
    Sour Acre Fold
    SK15 3DA Stalybridge
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Dairy
    Sour Acre Fold
    SK15 3DA Stalybridge
    Cheshire
    BritishDirector76523460001
    RYDE, Mark Heselgrase
    22 Heatherfield Road
    Marsh
    HD1 4QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    22 Heatherfield Road
    Marsh
    HD1 4QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAccountant77792730001
    SCHALLERT, Johann
    Sharston Road
    Wythenshawe
    M22 4TH Manchester
    Rufflette
    Amministratore
    Sharston Road
    Wythenshawe
    M22 4TH Manchester
    Rufflette
    AustrianDirector134064570001
    SUTTON, Paul Richard
    2 Hamilton Park
    N5 1SJ London
    Amministratore
    2 Hamilton Park
    N5 1SJ London
    BritishSolicitor61986290001

    RUFFLETTE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Goldcrest Distribution Limited
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 mar 2014
    Consegnato il 20 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The North West Fund for Business Loans LLP
    Transazioni
    • 20 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 gen 2014
    Consegnato il 06 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited (The ''Security Trustee'')
    Transazioni
    • 06 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 ott 2013
    Consegnato il 01 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 lug 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2002
    Consegnato il 28 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings adjoining sharston road sharston greater manchester proceeds of sale the benefit of all covenants and rights and the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Raiffeisen Zentralbank Osterreich Ag
    Transazioni
    • 28 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2001
    Consegnato il 08 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as bandex narrow textiles limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south east side of harling road sharston greater manchester. T/no. GM689389, l/h land and buildings adjoining sharston road sharston greater manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Raiffeisen Zentralbank Osterreigh Ag
    Transazioni
    • 08 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge created by the company (formerly known as bandex narrow textiles limited) and thomas french limited (as chargee)
    Creato il 30 mag 2001
    Consegnato il 01 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreements (as defined)
    Brevi particolari
    First legal mortgage upon the adjoining land and buildings on the south east side of harling road sharston greater manchester t/no;-GM689389 all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on the property first fixed charge on all plant and machinery at the property not charged by way of legal mortgage above and the benefit of all contracts and warranties relating thereto all monies under or pursuant to the insurances all tenants and trade fixtures and fittings all machinery equipment on the property belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas French Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge made between the company (formerly known as bandex narrow textiles limited) and french PLC (the chargee)
    Creato il 30 mag 2001
    Consegnato il 01 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreements (as defined)
    Brevi particolari
    First legal mortgage upon the adjoining land and buildings on the south east side of harling road sharston greater manchester t/no;-GM689389 all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on the property first fixed charge on all plant and machinery at the property not charged by way of legal mortgage above and the benefit of all contracts and warranties relating thereto all monies under or pursuant to the insurances all tenants and trade fixtures and fittings all machinery equipment on the property belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • French PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 dic 1999
    Consegnato il 19 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 15TH december 1999 relating to the provision of a loan facility of up to euro 950,000 and/or the charge
    Brevi particolari
    .. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bandex Textil & Handels-Gmbh
    Transazioni
    • 19 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RUFFLETTE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 lug 2014Inizio dell'amministrazione
    29 giu 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lindsey J Cooper
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0