HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED

HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03870666
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ADAMS AND REMERS SOLICITORS
    Trinity House
    School Hill
    BN7 2NN Lewes
    East Sussex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VALEMONTE LIMITED03 nov 199903 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al03 nov 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma17 nov 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Adms & Remers Secretarial Services Limited come segretario in data 04 ago 2014

    1 pagineTM02

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 nov 2009

    Stato del capitale al 12 nov 2009

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Adms & Remers Secretarial Services Limited il 11 nov 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Andrew James Currie il 11 nov 2009

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Adams * Remers Solicitors Trinity House School Hill Lewes East Sussex BN7 2NN* in data 12 nov 2009

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    11 pagine395

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    13 pagineAA

    legacy

    19 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CURRIE, Philip Andrew James
    Lansdowne
    Grayswood Road
    GU27 2BW Haselmere
    Surrey
    Amministratore
    Lansdowne
    Grayswood Road
    GU27 2BW Haselmere
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant74930470001
    BOOT, George Robert
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    Segretario
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    EnglishChartered Accountant94386190001
    GLADWELL, Lynn
    8 Appleby Close
    ME1 2BS Rochester
    Kent
    Segretario
    8 Appleby Close
    ME1 2BS Rochester
    Kent
    British72805410001
    NEGUS, Terence James
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    Segretario
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    BritishChartered Accountant40018190003
    OWEN, Caroline Elizabeth
    Brackley House Staplehurst Road
    Staplehurst
    TN12 0RJ Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Brackley House Staplehurst Road
    Staplehurst
    TN12 0RJ Tonbridge
    Kent
    BritishAccountant56406560002
    OWEN, Caroline Elizabeth
    Brackley House Staplehurst Road
    Staplehurst
    TN12 0RJ Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Brackley House Staplehurst Road
    Staplehurst
    TN12 0RJ Tonbridge
    Kent
    BritishAccountant56406560002
    RIVERS, David John Hamilton
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    Segretario
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    BritishManaging Director104735860001
    TURPIN, Carl Stephen
    Hollywood
    Warren Drive
    KT20 6PX Kingswood
    Surrey
    Segretario
    Hollywood
    Warren Drive
    KT20 6PX Kingswood
    Surrey
    BritishCertified Accountant85268420001
    WATKINS, Margaret Mary
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Segretario nominato
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900006760001
    ADMS & REMERS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    School Hill
    BN7 2NN Lewes
    Trinity House
    East Sussex
    England
    Segretario
    School Hill
    BN7 2NN Lewes
    Trinity House
    East Sussex
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06910686
    140357480001
    BOOT, George Robert
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    Amministratore
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    EnglandEnglishChartered Accountant94386190001
    DEIR, Zaher
    The Penthouse
    5-7 Clifton Crescent
    CT20 2EL Folkestone
    Kent
    Amministratore
    The Penthouse
    5-7 Clifton Crescent
    CT20 2EL Folkestone
    Kent
    United KingdomBritishDirector95289590001
    JOHNSON, Christopher Charles
    Combe House
    Combe Bank Drive
    TN14 6AD Sundridge
    Kent
    Amministratore
    Combe House
    Combe Bank Drive
    TN14 6AD Sundridge
    Kent
    United KingdomBritishDirector9209400004
    LOW, John David
    Watermead House
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Watermead House
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    BritishDirector427690002
    MCCOLLUM, Angela Jean
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Amministratore delegato nominato
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900006750001
    NEGUS, Terence James
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    Amministratore
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant40018190003
    OWEN, Caroline Elizabeth
    Brackley House Staplehurst Road
    Staplehurst
    TN12 0RJ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Brackley House Staplehurst Road
    Staplehurst
    TN12 0RJ Tonbridge
    Kent
    BritishAccountant56406560002
    PAYNE, Conrad Francis Charles Presgrave
    19 Church Street
    TN5 7AH Ticehurst
    East Sussex
    Amministratore
    19 Church Street
    TN5 7AH Ticehurst
    East Sussex
    BritishCompany Director48595620002
    PAYNE, Conrad Francis Charles Presgrave
    1 Nevill Park
    TN4 8NW Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    1 Nevill Park
    TN4 8NW Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector48595620001
    RIVERS, David John Hamilton
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    Amministratore
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    EnglandBritishDirector104735860001
    RIVERS, David John Hamilton
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    Amministratore
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    EnglandBritishDirector104735860001
    STREETEN, Jeremy Douglas Renwick
    Roughway Cottage
    Roughway Plaxtol
    TN11 9SN Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Roughway Cottage
    Roughway Plaxtol
    TN11 9SN Tonbridge
    Kent
    BritishDirector54753180001
    TURPIN, Carl Stephen
    Hollywood
    Warren Drive
    KT20 6PX Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Hollywood
    Warren Drive
    KT20 6PX Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritishCertified Accountant85268420001
    WINSKELL, Ian Michael
    52 Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    52 Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishSolicitor78627110001

    HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 12 gen 2009
    Consegnato il 20 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Facility and Security Agent for National Westminister Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Amendment deed
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including book debts buildings fixtures plant and machinery (for details of properties charged please refer to form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2008
    Consegnato il 27 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Each and all of the business, assets, property, undertaking and other interests from time to time assigned or charged see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 27 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Third party charge over cash deposit and account
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 03 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from eagle property company limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit and the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Accession deed
    Creato il 20 gen 2005
    Consegnato il 26 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies,obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Accession deed to a group debenture dated 21 december 2004
    Creato il 21 dic 2004
    Consegnato il 24 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 24 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 10 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or honeygrove properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 22 feb 2000
    Consegnato il 09 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking, property and assets of the company, whatsoever and wheresoever, present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 2000
    Consegnato il 25 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,350,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Swaylands penhurst kent t/n K746002; piece of and adjoining swaylands. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barton House (No 41) Limited
    Transazioni
    • 25 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 2000
    Consegnato il 23 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a swaylands (formerly swaylands school) penshurst kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HONEYGROVE (SWAYLANDS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 mag 2011Inizio della liquidazione
    13 apr 2011Data della petizione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Brighton
    69 Middle Street
    Brighton
    BN1 1BE
    Praticante
    69 Middle Street
    Brighton
    BN1 1BE

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0