SITEMAKER SOFTWARE LIMITED

SITEMAKER SOFTWARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSITEMAKER SOFTWARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03871424
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Forbury Place
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GREEK ATTIC LIMITED12 nov 200212 nov 2002
    COLLABORATIVE FILING LIMITED14 mar 200114 mar 2001
    LYNXLAW ONLINE LIMITED04 nov 199904 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Adam Howard Hurst come amministratore in data 17 mar 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Robert Kenneth Hall come amministratore in data 17 mar 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Claire Miles come amministratore in data 31 dic 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 set 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 038714240007

    1 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Restructuring and terms of and transactions contemplated by the relevant documents are approved 08/03/2022
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    21 pagineAA

    Nomina di Paul William Manwaring come segretario in data 01 ago 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christian Henry Wells come segretario in data 01 ago 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Adam Howard Hurst come amministratore in data 18 gen 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Robert Arthur Ainslie come amministratore in data 18 gen 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    23 pagineAA

    Cessazione della carica di Oliver Edward James Wilson come amministratore in data 24 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Robert Arthur Ainslie come amministratore in data 24 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David William Henry Sharman come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mrs Claire Miles come amministratore in data 08 ott 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MANWARING, Paul William
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Segretario
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    285891080001
    HALL, Robert Kenneth
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish209336560002
    STARR, Alison
    20 Goldhurst Terrace
    NW6 3HU London
    Segretario
    20 Goldhurst Terrace
    NW6 3HU London
    British77583120001
    TAN, Wendy Thida
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    Segretario
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    British81443570001
    WELLS, Christian Henry
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Segretario
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    186932620001
    WHITE, Joe
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    Segretario
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    British93830890001
    AINSLIE, Michael Robert Arthur
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    EnglandBritish26895460003
    BATES, Antony Jeffrey
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    Hibu
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    Hibu
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish171362900001
    ECKERT, David Alan
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    UsaAmerican183726760001
    GREEN, Malcolm Laurence
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    EnglandBritish132345080001
    HALL, Robert Kenneth
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish209336560001
    HANSCOTT, Richard John
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    EnglandBritish161969000001
    HURST, Adam Howard
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    EnglandBritish75631000003
    MILES, Claire
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    EnglandBritish175702430002
    PETTERSEN, Eirik Keith
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    EnglandBritish81443650004
    PETTERSEN, Eirik Keith
    26-28 Bartholomew Square
    EC1V 3QH London
    Flat 4
    United Kingdom
    Amministratore
    26-28 Bartholomew Square
    EC1V 3QH London
    Flat 4
    United Kingdom
    EnglandBritish81443650004
    RUSSO, Paul
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    EnglandAmerican187149880001
    SHARMAN, David William Henry
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish256030500001
    STARR, Toby
    20 Goldhurst Terrace
    NW6 3HU London
    Amministratore
    20 Goldhurst Terrace
    NW6 3HU London
    British66813850003
    TAN, Wendy Thida
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    Amministratore
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    British81443570001
    WELLS, Christian Henry
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    EnglandBritish154299770001
    WELLS, Christian Henry
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    Hibu
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    Hibu
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154299770001
    WHITE, Joe
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    Amministratore
    31a Batoum Gardens
    W6 7QB London
    United KingdomBritish93830890001
    WHITE, Joseph Lawrence
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    EnglandBritish106749190001
    WHITE, Wendy
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    EnglandBritish160128910001
    WHITE, Wendy
    Batoum Gardens
    W6 7QB London
    31a
    England
    Amministratore
    Batoum Gardens
    W6 7QB London
    31a
    England
    EnglandBritish160128910001
    WILSON, Oliver Edward James
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    3 Forbury Place
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish209272940002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SITEMAKER SOFTWARE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    06 apr 2016
    Forbury Road
    RG1 3YL Reading
    One Reading Central
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione7298668
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SITEMAKER SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 mag 2018
    Consegnato il 08 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trustees Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 set 2022Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 07 set 2016
    Consegnato il 09 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Global Loan Agency Services Limited
    Transazioni
    • 09 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 mar 2014
    Consegnato il 05 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Suite 340, 50 eastcastle street, london. Suite 210, 50 eastcastle street, london.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Global Loan Agency Services Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 05 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 set 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 02 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 19 ott 2012
    Consegnato il 25 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £7,350 paid in a separately desginated deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mount Eden Land Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 ago 2011
    Consegnato il 18 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First legal charge the deposited sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mount Eden Land Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 dic 2009
    Consegnato il 11 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mount Eden Land Limited
    Transazioni
    • 11 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 giu 2006
    Consegnato il 23 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal charge and with full title guarantee the deposited sum. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mount Eden Land Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SITEMAKER SOFTWARE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 set 2022Inizio della liquidazione
    15 lug 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Caroline Rifkind
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0