COBB SLATER LIMITED

COBB SLATER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOBB SLATER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03874319
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COBB SLATER LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova COBB SLATER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Marys House
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COBB SLATER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EVER 1230 LIMITED10 nov 199910 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di COBB SLATER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per COBB SLATER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Paul Gregory Wood come amministratore in data 01 lug 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2012

    Stato del capitale al 21 nov 2012

    • Capitale: GBP 999.9
    SH01

    Nomina di Mr Derek Steven Mansfield come amministratore in data 03 gen 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Neil Keith Partlett come amministratore in data 31 ott 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Arun Nagwaney come amministratore in data 16 set 2011

    2 pagineTM01

    Nomina di Paul Gregory Wood come amministratore in data 16 set 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Nicholas Martin Ball come amministratore in data 16 set 2011

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Faisal John Rahmatallah il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    20 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2007

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    10 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di COBB SLATER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALL, Nicholas Martin
    30 Alderside Walk
    Englefield Green
    TW20 0LY Egham
    Surrey
    Segretario
    30 Alderside Walk
    Englefield Green
    TW20 0LY Egham
    Surrey
    British109418860001
    BALL, Nicholas Martin
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    St Mary's House
    Uk
    Amministratore
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    St Mary's House
    Uk
    EnglandBritishGroup Finance Director109418860001
    MANSFIELD, Derek Steven
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    St Marys House
    Amministratore
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    St Marys House
    United KingdomBritishCeo169129420001
    RAHMATALLAH, Faisal John
    St Johns Avenue
    SW15 2AA London
    18
    United Kingdom
    Amministratore
    St Johns Avenue
    SW15 2AA London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritishBusinessman93240170002
    DALY, Michael Edmund
    103 The Gills
    LS21 2BY Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    103 The Gills
    LS21 2BY Otley
    West Yorkshire
    BritishAccountant72225410001
    MELLING, Dawn Gillian
    7 Albanus Ridge
    Stannington
    S6 6EX Sheffield
    Yorkshire
    Segretario
    7 Albanus Ridge
    Stannington
    S6 6EX Sheffield
    Yorkshire
    BritishAccountant42932770001
    REED, Christopher Terry
    93 Hookstone Drive
    HG2 8PH Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    93 Hookstone Drive
    HG2 8PH Harrogate
    North Yorkshire
    BritishAccountant83775910001
    RIGBY, Jennifer Ann
    Hough Hole House Hough Hole
    Rainow
    SK10 5UW Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Hough Hole House Hough Hole
    Rainow
    SK10 5UW Macclesfield
    Cheshire
    British13437470002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Sun Alliance House
    35 Mosley Street
    NE1 1AN Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    Sun Alliance House
    35 Mosley Street
    NE1 1AN Newcastle Upon Tyne
    900018440001
    CALVERT, Robert
    21 Hodder Close
    Crich
    DE4 5NH Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    21 Hodder Close
    Crich
    DE4 5NH Matlock
    Derbyshire
    BritishTechnical Director69475800002
    CLEARY, Niall John Miles
    13 Dunholme Road
    Welton
    LN2 3RS Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    13 Dunholme Road
    Welton
    LN2 3RS Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritishOperations Director111633120001
    GARNETT, David Morris
    Highfield House
    Burley Woodhead
    LS29 7AS Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Highfield House
    Burley Woodhead
    LS29 7AS Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director4205100001
    NAGWANEY, Arun
    59 Portobello Road
    W11 3DB London
    Amministratore
    59 Portobello Road
    W11 3DB London
    EnglandBritishBusinessman123339780001
    PARTLETT, Neil Keith, Dr
    6 Grey Towers Hall Wyke Lane
    Nunthorpe
    TS7 0GD Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    6 Grey Towers Hall Wyke Lane
    Nunthorpe
    TS7 0GD Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritishDirector73617910002
    REED, Christopher Terry
    93 Hookstone Drive
    HG2 8PH Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    93 Hookstone Drive
    HG2 8PH Harrogate
    North Yorkshire
    BritishAccountant83775910001
    RIGBY, Andrew Peter
    Hough Hole House
    Sugar Lane Rainow
    SK10 5UW Macclesfield
    Amministratore
    Hough Hole House
    Sugar Lane Rainow
    SK10 5UW Macclesfield
    EnglandBritishCompany Director13437480002
    TETLOW, David
    276 Main Street
    Wilsden
    BD15 0JR Bradford
    Amministratore
    276 Main Street
    Wilsden
    BD15 0JR Bradford
    BritishSales Director69475650004
    WOOD, Paul Gregory
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    St Mary's House
    Uk
    Amministratore
    42 Vicarage Crescent
    SW11 3LD London
    St Mary's House
    Uk
    EnglandBritishFinance Director126754800001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Sun Alliance House
    35 Mosley Street
    NE1 1AN Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    Sun Alliance House
    35 Mosley Street
    NE1 1AN Newcastle Upon Tyne
    900018430001

    COBB SLATER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    The charge details have been removed pursuant to an order of court (please see ML28/order of court)
    Creato il 02 ago 2007
    Consegnato il 22 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    The charge details have been removed pursuant to an order of court (please see ML28/order of court)
    Brevi particolari
    The charge details have been removed pursuant to an order of court (please see ML28/order of court).
    Persone aventi diritto
    • The Charge Details Have Been Removed Pursuant to an Order of Court (Please See ML28/Order of Court)
    Transazioni
    • 22 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2008
    Debenture
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 08 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 apr 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge and floating charge
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 14 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under a discounting agreement or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge (1) all receivables purchased or purported to be purchased by the security holder from the company (1) fixed equitable charge all purchased debts and the other debts etc (2) floating charge such of the monies received etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 14 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 apr 2000
    Consegnato il 19 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as ever 1230 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a cosim works dale road north darley dale matlock derbyshire and the south west side of A6 darley dale matlock derbyshire. T/no. DY225676 & DY282965. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 apr 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 apr 2000
    Consegnato il 05 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nigel Coatman(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 ott 1997
    Acquisito il 03 apr 2000
    Consegnato il 18 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cosim works dale road north darley dale matlock derbyshire and land on the south west side of A6 darley dale - DY225676 DY282965.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 1990
    Acquisito il 03 apr 2000
    Consegnato il 18 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All property assets and undertaking.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0