COBB SLATER LIMITED
Panoramica
Nome della società | COBB SLATER LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03874319 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COBB SLATER LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere
Dove si trova COBB SLATER LIMITED?
Indirizzo della sede legale | St Marys House 42 Vicarage Crescent SW11 3LD London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COBB SLATER LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
EVER 1230 LIMITED | 10 nov 1999 | 10 nov 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COBB SLATER LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per COBB SLATER LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Gregory Wood come amministratore in data 01 lug 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Derek Steven Mansfield come amministratore in data 03 gen 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Keith Partlett come amministratore in data 31 ott 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Arun Nagwaney come amministratore in data 16 set 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Paul Gregory Wood come amministratore in data 16 set 2011 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicholas Martin Ball come amministratore in data 16 set 2011 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Faisal John Rahmatallah il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 20 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 6 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2007 | 8 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 10 pagine | 363s | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a |
Chi sono gli amministratori di COBB SLATER LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL, Nicholas Martin | Segretario | 30 Alderside Walk Englefield Green TW20 0LY Egham Surrey | British | 109418860001 | ||||||
BALL, Nicholas Martin | Amministratore | 42 Vicarage Crescent SW11 3LD London St Mary's House Uk | England | British | Group Finance Director | 109418860001 | ||||
MANSFIELD, Derek Steven | Amministratore | 42 Vicarage Crescent SW11 3LD London St Marys House | United Kingdom | British | Ceo | 169129420001 | ||||
RAHMATALLAH, Faisal John | Amministratore | St Johns Avenue SW15 2AA London 18 United Kingdom | United Kingdom | British | Businessman | 93240170002 | ||||
DALY, Michael Edmund | Segretario | 103 The Gills LS21 2BY Otley West Yorkshire | British | Accountant | 72225410001 | |||||
MELLING, Dawn Gillian | Segretario | 7 Albanus Ridge Stannington S6 6EX Sheffield Yorkshire | British | Accountant | 42932770001 | |||||
REED, Christopher Terry | Segretario | 93 Hookstone Drive HG2 8PH Harrogate North Yorkshire | British | Accountant | 83775910001 | |||||
RIGBY, Jennifer Ann | Segretario | Hough Hole House Hough Hole Rainow SK10 5UW Macclesfield Cheshire | British | 13437470002 | ||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Segretario nominato | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1AN Newcastle Upon Tyne | 900018440001 | |||||||
CALVERT, Robert | Amministratore | 21 Hodder Close Crich DE4 5NH Matlock Derbyshire | British | Technical Director | 69475800002 | |||||
CLEARY, Niall John Miles | Amministratore | 13 Dunholme Road Welton LN2 3RS Lincoln Lincolnshire | England | British | Operations Director | 111633120001 | ||||
GARNETT, David Morris | Amministratore | Highfield House Burley Woodhead LS29 7AS Ilkley West Yorkshire | British | Company Director | 4205100001 | |||||
NAGWANEY, Arun | Amministratore | 59 Portobello Road W11 3DB London | England | British | Businessman | 123339780001 | ||||
PARTLETT, Neil Keith, Dr | Amministratore | 6 Grey Towers Hall Wyke Lane Nunthorpe TS7 0GD Middlesbrough Cleveland | United Kingdom | British | Director | 73617910002 | ||||
REED, Christopher Terry | Amministratore | 93 Hookstone Drive HG2 8PH Harrogate North Yorkshire | British | Accountant | 83775910001 | |||||
RIGBY, Andrew Peter | Amministratore | Hough Hole House Sugar Lane Rainow SK10 5UW Macclesfield | England | British | Company Director | 13437480002 | ||||
TETLOW, David | Amministratore | 276 Main Street Wilsden BD15 0JR Bradford | British | Sales Director | 69475650004 | |||||
WOOD, Paul Gregory | Amministratore | 42 Vicarage Crescent SW11 3LD London St Mary's House Uk | England | British | Finance Director | 126754800001 | ||||
EVERDIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1AN Newcastle Upon Tyne | 900018430001 |
COBB SLATER LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
The charge details have been removed pursuant to an order of court (please see ML28/order of court) | Creato il 02 ago 2007 Consegnato il 22 ago 2007 | In corso | Importo garantito The charge details have been removed pursuant to an order of court (please see ML28/order of court) | |
Brevi particolari The charge details have been removed pursuant to an order of court (please see ML28/order of court). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 apr 2004 Consegnato il 08 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 03 apr 2003 Consegnato il 04 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge and floating charge | Creato il 13 dic 2000 Consegnato il 14 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under a discounting agreement or otherwise | |
Brevi particolari By way of fixed equitable charge (1) all receivables purchased or purported to be purchased by the security holder from the company (1) fixed equitable charge all purchased debts and the other debts etc (2) floating charge such of the monies received etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 03 apr 2000 Consegnato il 19 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as ever 1230 limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a cosim works dale road north darley dale matlock derbyshire and the south west side of A6 darley dale matlock derbyshire. T/no. DY225676 & DY282965. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 03 apr 2000 Consegnato il 06 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 apr 2000 Consegnato il 05 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 17 ott 1997 Acquisito il 03 apr 2000 Consegnato il 18 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Cosim works dale road north darley dale matlock derbyshire and land on the south west side of A6 darley dale - DY225676 DY282965. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 nov 1990 Acquisito il 03 apr 2000 Consegnato il 18 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All property assets and undertaking. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0