AMC (UK) ACQUISITION LIMITED

AMC (UK) ACQUISITION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMC (UK) ACQUISITION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03878599
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ODEON CINEMAS GROUP LIMITED25 feb 200025 feb 2000
    FAMEALPHA LIMITED17 nov 199917 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW

    2 pagineAD03

    Indirizzo della sede legale modificato da No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ a No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ in data 16 gen 2018

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX a No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ in data 16 gen 2018

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 dic 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Notifica di Odeon and Uci Cinemas Group Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Odeon Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2017

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr John Brooks Rainer come amministratore in data 20 nov 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Ray Ramsey come amministratore in data 20 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Craig Ray Ramsey come amministratore in data 20 nov 2017

    1 pagineTM01

    Stato del capitale al 02 ott 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Craig Ray Ramsey come amministratore in data 06 lug 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Craig Ray Ramsey come amministratore in data 06 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Stephen Alker come amministratore in data 06 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil James Williams come amministratore in data 06 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Jonathan Way come amministratore in data 06 lug 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAWTON, Kirsten
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Segretario
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    British50045660003
    RAINER, John Brooks
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Amministratore
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    United StatesAmerican239691240001
    CAULTON, Lisa Victoria
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    Segretario
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    British68461080001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    British124301460001
    HANLON, Hugh Ronald Victor
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    Segretario
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    British69843660001
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Segretario
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    British99741450001
    MOORE, Gordon James
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Segretario
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British64281120002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Segretario
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ALKER, Andrew Stephen
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Amministratore
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritish120642230001
    ARNOLD, Gary Kenneth
    8 The Wirrals
    ME5 0NT Chatham
    Kent
    Amministratore
    8 The Wirrals
    ME5 0NT Chatham
    Kent
    British89207860001
    CAULTON, Lisa Victoria
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    Amministratore
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    British68461080001
    CHADD, Andrew Peter
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    Amministratore
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    United KingdomBritish133578890002
    DONOVAN, Paul Michael
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish154988050002
    GAVIN, Alexander Rupert, Sir
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Amministratore
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish16875680002
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124301460001
    HANLON, Hugh Ronald Victor
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    Amministratore
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    British69843660001
    HARRIS, Roger John
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Amministratore
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish129109390001
    ISPAHANI, Farah Khanum
    30 Mount Ararat Road
    TW10 6PG Richmond
    Surrey
    Amministratore
    30 Mount Ararat Road
    TW10 6PG Richmond
    Surrey
    British68461020002
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Amministratore
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    British99741450001
    KEWARD, Barry James
    12 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    12 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British96966030001
    MASON, Jonathan Peter
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Amministratore
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish117783520001
    MOORE, Gordon James
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Amministratore
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British64281120002
    MUNTON, Richard James
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    British11882410003
    O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Amministratore
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Irish89259830001
    PRIDAY, Stuart Richard
    72 Humphries Drive
    NN13 6PW Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    72 Humphries Drive
    NN13 6PW Brackley
    Northamptonshire
    British89207570001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Amministratore
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritish58870910002
    RAMSEY, Craig Ray
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Amministratore
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    UsaAmerican235440400001
    RAMSEY, Craig Ray
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Amministratore
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    UsaAmerican235473170001
    RITVAY, Alexander Tibor Mihaly, Dr
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    Amministratore
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    German95639320001
    SEGAL, Richard Lawrence
    16 Spencer Drive
    N2 0QX London
    Amministratore
    16 Spencer Drive
    N2 0QX London
    United KingdomBritish47031800003
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Amministratore
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    STEEL, Amanda Jayne
    Swinbrook
    Station Road Shiplake
    RG9 3JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Swinbrook
    Station Road Shiplake
    RG9 3JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish126903200001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Odeon And Uci Cinemas Group Limited
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House, 57-59 Haymarket
    United Kingdom
    30 nov 2017
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House, 57-59 Haymarket
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies
    Numero di registrazione5194610
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Odeon Limited
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    57-59
    England
    06 apr 2016
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    57-59
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies, Cardiff
    Numero di registrazione3879590
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    AMC (UK) ACQUISITION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 mag 2011
    Consegnato il 07 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from odeon & uci bond midco limited or any restricted subsidiary to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon
    Transazioni
    • 07 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 16 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest from time to time in and to each of the following assets the material property other than the excluded property the tangible movable property the accounts the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 16 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 16 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any obligor to the chargee (the security agent as agent and trustee for the secured parties), the loan note holder and any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The material property other than the excluded property; the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights; all monetary claims and all related rights; and any other contract or agreement to which the company is a party (other than the specific contracts) and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 set 2004
    Consegnato il 24 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 24 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all of the property specified (for full details of property charged please see schedule to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westlb Ag
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Borrower debenture
    Creato il 16 dic 2002
    Consegnato il 02 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the borrower secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right title interest and benefit present and future in fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York London Branch
    Transazioni
    • 02 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over bank account
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 09 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Expenditure required under the planned multiplex projects (as defined) in accordance with the terms of the credit agreement (as defined) and any moneys required to be repaid by the company to the chargee which have been drawn down pursuant to clause 8 of the investors and shareholders agreement (as defined) for planned multiplex projects but are not so required
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to all sums deposited or to be deposited in the account and all other sums from time to time standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cinven Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture between (1) aceream limited (now known as odeon limited) (the parent) and others (including famealpha limited now known as odeon cinemas group limited) (as charging companies) and (2) merrill lynch international (as security agent)
    Creato il 19 feb 2000
    Consegnato il 06 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due to the secured parties (as defined) (or any of them) by each charging company and each of the other obligors (as defined) (or any of them) under the senior finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merrill Lynch International as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 06 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    AMC (UK) ACQUISITION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 nov 2018Data di scioglimento
    19 dic 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0