AMICUS ITS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMICUS ITS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03879859
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di AMICUS ITS LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Riparazione di apparecchiature informatiche e periferiche (95110) / Altre attività di servizi

    Dove si trova AMICUS ITS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1-2 Trinity Court Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    Hampshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMICUS ITS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARMONI ITS LIMITED22 mag 200622 mag 2006
    WORLD CLASS INTERNATIONAL LIMITED03 gen 200303 gen 2003
    WORLD CLASS INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED09 gen 200109 gen 2001
    2GL COMPUTER SERVICES GROUP LIMITED18 nov 199918 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMICUS ITS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2026
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2025

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per AMICUS ITS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al30 giu 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 lug 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al30 giu 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per AMICUS ITS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di James Jerold Reed come amministratore in data 31 mar 2026

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 05 apr 2025

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Richard Flanders come amministratore in data 01 ott 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr James Jerold Reed come amministratore in data 01 ott 2025

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2024

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 038798590012 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2023

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Peter Storrar come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1-2 Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX England a 1-2 Trinity Court Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX in data 22 giu 2022

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1-3 Trinity Court, Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX England a 1-2 Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX in data 22 giu 2022

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 038798590011 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da 15-17 Cumberland House Grosvenor Square Southampton Hampshire SO15 2BG England a Unit 1-3 Trinity Court, Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX in data 19 nov 2019

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 038798590013, creata il 05 nov 2019

    17 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 038798590012, creata il 05 nov 2019

    25 pagineMR01

    Cessazione della carica di Steven Bob Jackson come amministratore in data 05 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Leslie Donald Keen come amministratore in data 05 nov 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di AMICUS ITS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FLANDERS, Richard
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritish341371970001
    NORMAN, John Paul
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritish205721960001
    WALKER, Timothy Michael
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish126232940001
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    British173856420001
    GORDON, Alan
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    British131200010001
    TIMS, Jonathan Paul
    182 Castle Street
    Portchester
    PO16 9QH Fareham
    Hampshire
    Segretario
    182 Castle Street
    Portchester
    PO16 9QH Fareham
    Hampshire
    British91844860001
    WOODS, Mark Kevin
    Glenbourne Woodland Mews
    West End
    SO30 3DF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Glenbourne Woodland Mews
    West End
    SO30 3DF Southampton
    Hampshire
    British57308640001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    ALBERT, Dave
    Collington Avenue
    TN39 3RA Bexhill On Sea
    76
    East Sussex
    Amministratore
    Collington Avenue
    TN39 3RA Bexhill On Sea
    76
    East Sussex
    British132706090001
    APPS, Judith Caroline
    Paramount
    Deanery Road
    GU7 2PG Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Paramount
    Deanery Road
    GU7 2PG Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71431990001
    ATKINS, Andrew Peter
    Penny Cottage
    Church Lane
    SP5 1JY West Tytherley
    Hampshire
    Amministratore
    Penny Cottage
    Church Lane
    SP5 1JY West Tytherley
    Hampshire
    British64619800002
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritish125262390001
    CHEESEMAN, David George
    14 Marina Drive
    Hamble
    SO31 4PJ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    14 Marina Drive
    Hamble
    SO31 4PJ Southampton
    Hampshire
    British90164600001
    COLLINS, Paul Eric
    Littlecroft, 18 Gong Hill Drive
    Lower Bourne
    GU10 3HQ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Littlecroft, 18 Gong Hill Drive
    Lower Bourne
    GU10 3HQ Farnham
    Surrey
    EnglandBritish11243510002
    DERRICK, Simon John
    Crossfield
    Hightown Hill
    BH24 3HG Ringwood
    Hants
    Amministratore
    Crossfield
    Hightown Hill
    BH24 3HG Ringwood
    Hants
    British2264060002
    EASTON, James William
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish118320980001
    EVANS, Carol Lesley
    65 Withy Close
    SO51 7SA Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    65 Withy Close
    SO51 7SA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish122236710001
    GARDNER, Andrew Philip
    Romsey Road
    SO22 5PG Winchester
    199
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Romsey Road
    SO22 5PG Winchester
    199
    Hampshire
    United Kingdom
    UkBritish70433100004
    GORDON, Alan Nicholas Chesterfield
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish83904050001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    JACKSON, Steven Bob
    Grosvenor Square
    SO15 2BG Southampton
    15-17 Cumberland House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Grosvenor Square
    SO15 2BG Southampton
    15-17 Cumberland House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish205977190001
    JACKSON, Steven Bob
    Matley Cottage
    Beaulieu Road
    SO43 7FZ Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Matley Cottage
    Beaulieu Road
    SO43 7FZ Lyndhurst
    Hampshire
    British50218490004
    KANDIAH, Andrew Sicam
    279 Botley Road
    Burridge
    SO31 1BS Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    279 Botley Road
    Burridge
    SO31 1BS Southampton
    Hampshire
    British40601840002
    KEEN, Leslie Donald
    Grosvenor Square
    SO15 2BG Southampton
    15-17 Cumberland House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Grosvenor Square
    SO15 2BG Southampton
    15-17 Cumberland House
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish119095680001
    MARRINER, David Ronald
    1 Greenfinch Close
    RG45 6TZ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    1 Greenfinch Close
    RG45 6TZ Crowthorne
    Berkshire
    British25695220002
    MELDRUM, Alan
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    Unit 1-3 Trinity Court
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    Unit 1-3 Trinity Court
    England
    EnglandBritish201139470001
    MOORE, Kim Cheryl Moore
    22 Alderwood Avenue
    Ashley Wood
    SO5 3TH Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    22 Alderwood Avenue
    Ashley Wood
    SO5 3TH Chandlers Ford
    Hampshire
    British11949720003
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish151240810001
    REED, James Jerold
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritish212371180001
    SEDDON, David
    18 Saint Marks Crescent
    SL6 5DB Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    18 Saint Marks Crescent
    SL6 5DB Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish67794540002
    STEPHENS, Graham Martin
    25 St Michaels Close
    North Waltham
    RG25 2BP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    25 St Michaels Close
    North Waltham
    RG25 2BP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish79564090001
    STORRAR, Peter
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    1-2 Trinity Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritish205720490001
    TIMS, Jonathan Paul
    Myrtle Cottage
    182 Castle Street, Portchester
    PO16 9QH Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Myrtle Cottage
    182 Castle Street, Portchester
    PO16 9QH Fareham
    Hampshire
    EnglandEnglish14688760002
    TIZZARD, James
    1 Abbeyfields Drive
    B80 7BF Studley
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Abbeyfields Drive
    B80 7BF Studley
    Warwickshire
    British90164750001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AMICUS ITS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Amicus Holdings Limited
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    Units 1-3 Trinity Court
    England
    06 apr 2016
    Brunel Road
    Totton
    SO40 3WX Southampton
    Units 1-3 Trinity Court
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione09787839
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0