ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED

ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03880999
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Swiss House
    Beckingham Street
    CM9 8LZ Tolleshunt Major
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE ABBEY ROAD CASTLE LIMITED13 set 200513 set 2005
    THE MANHATTAN LOFT CORPORATION (AR) LIMITED22 nov 199922 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Miss Agnieszka Maria Sleczka come segretario in data 03 mar 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Centrum Secretaries Limited come segretario in data 03 mar 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Miss Agnieszka Maria Sleczka come amministratore in data 03 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Pearlman come amministratore in data 03 mar 2015

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 ott 2014 al 30 set 2014

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Robert Benjamin Gersohn come segretario in data 14 nov 2014

    2 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 dic 2013

    Stato del capitale al 03 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2011

    7 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Suite 1 South House Lodge Off Mundon Road Maldon Essex CM9 6PP United Kingdom

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Mary Stephen come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Robert Benjamin Gersohn come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2010

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Suite 1 South House Lodge Off Mundon Road Maldon Essex CM9 6PP* in data 18 mag 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SLECZKA, Agnieszka Maria
    Beckingham Street
    CM9 8LZ Tolleshunt Major
    Swiss House
    Essex
    Segretario
    Beckingham Street
    CM9 8LZ Tolleshunt Major
    Swiss House
    Essex
    202307490001
    SLECZKA, Agnieszka Maria
    Beckingham Street
    CM9 8LZ Tolleshunt Major
    Swiss House
    Essex
    Amministratore
    Beckingham Street
    CM9 8LZ Tolleshunt Major
    Swiss House
    Essex
    EnglandPolish202306860001
    BHAMBRA, Harjeet
    62 Byron Avenue
    Manor Park
    E12 6NG London
    Segretario
    62 Byron Avenue
    Manor Park
    E12 6NG London
    British32700280001
    CHICK, Lesley Anne
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    Segretario nominato
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    British900008230001
    GERSOHN, Robert Benjamin
    Finchley Road
    NW11 7TJ London
    788-790
    United Kingdom
    Segretario
    Finchley Road
    NW11 7TJ London
    788-790
    United Kingdom
    British165237350001
    STEPHEN, Mary Philomena
    6 Burnham Close
    NW7 2SE London
    Segretario
    6 Burnham Close
    NW7 2SE London
    British64218710002
    VRANKOVIC, Maria
    29 Haileybury Avenue
    EN1 1JJ Enfield
    Middlesex
    Segretario
    29 Haileybury Avenue
    EN1 1JJ Enfield
    Middlesex
    British83828650002
    CENTRUM SECRETARIES LIMITED
    Finchley Road
    NW11 7TJ London
    788-790
    United Kingdom
    Segretario
    Finchley Road
    NW11 7TJ London
    788-790
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04193935
    128429450001
    HANDELSMAN, Harry
    Flat 1
    2 Hyde Park Gardens
    W2 2LT London
    Amministratore
    Flat 1
    2 Hyde Park Gardens
    W2 2LT London
    EnglandBritish124385660001
    PEARLMAN, David
    36 Asmuns Hill
    NW11 6ET London
    Amministratore
    36 Asmuns Hill
    NW11 6ET London
    United KingdomBritish23927810001
    REDDING, Diana Elizabeth
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    EnglandBritish900004650001
    STEPHEN, Mary Philomena
    6 Burnham Close
    NW7 2SE London
    Amministratore
    6 Burnham Close
    NW7 2SE London
    EnglandBritish64218710002

    ABBEY ROAD DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of rental income
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 31 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The rent account and all its right, title and interest in the monies from time to time standing to the credit of the rent account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 31 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that l/h land known as abbey roadbaptist church, abbey road, london t/no: NGL904070 by way of fixed charge all plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 2008
    Consegnato il 23 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Abbey road baptist church and school abbey road london by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security assignment of agreement for lease
    Creato il 28 lug 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of security the benefit of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of agreement
    Creato il 28 lug 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and squareford limited to the chargee
    Brevi particolari
    The company assigns the agreement by way of security and charges all the lessee's interest in the site. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of agreement for lease
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 02 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement dated 13 june 2002. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 02 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of agreement with authority or corporation re agreement for lease
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 02 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and squareford limited to chargee
    Brevi particolari
    Assigns the agreement dated 13 june 2002 for the completion of building works on the site. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 02 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Abbey road church and school abbey road london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0