9K GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società9K GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03884981
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 9K GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova 9K GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lindred House 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 9K GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PHOENIX IT SERVICES LIMITED24 set 201924 set 2019
    PHOENIX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED26 nov 199926 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di 9K GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per 9K GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    13 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name29 ott 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 29 ott 2019

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name24 set 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 set 2019

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Alan Smith il 23 ago 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Daisy It Group Limited come persona con controllo significativo il 29 apr 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR in data 29 apr 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di David Lewis Mcglennon come segretario in data 01 feb 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Nathan Richard Marke come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr David Lewis Mcglennon come amministratore in data 22 giu 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Keith Muller come amministratore in data 22 giu 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Matthew Robinson Riley come amministratore in data 24 ott 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di 9K GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGLENNON, David Lewis
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish181536600001
    SMITH, Stephen Alan
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish161471940001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    MARTIN, William Thomas
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Segretario
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    British57302660001
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Segretario
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    199438790001
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Segretario
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    British80817560001
    STOKES, Reeta
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    173995630001
    TAYLOR, David
    The Old Rectory
    Bishampton Road, Flyford Flavell
    WR7 4BT Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    The Old Rectory
    Bishampton Road, Flyford Flavell
    WR7 4BT Worcester
    Worcestershire
    British1439590004
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    179704070001
    HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    Segretario nominato
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    900002670001
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish294355310001
    CLUTTON, Steven
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish158222570001
    COURTLEY, David John
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish141213480001
    FARROW, Matthew James
    34 Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    Amministratore
    34 Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    EnglandBritish194105960001
    MARKE, Nathan Richard
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish194292450001
    MARTIN, William Thomas
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    United KingdomBritish57302660001
    MULLER, Neil Keith
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    EnglandBritish252490400001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish178585250001
    ROBINSON, Nicholas John
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish54873290006
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British54873290005
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Amministratore
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritish80817560001
    STAFFORD, Jeremy John
    The Old Rectory
    Lower Weald, Calverton
    MK19 6EE Milton Keynes
    Bucks
    Amministratore
    The Old Rectory
    Lower Weald, Calverton
    MK19 6EE Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish116431970001
    TAYLOR, David
    The Old Rectory
    Bishampton Road, Flyford Flavell
    WR7 4BT Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Bishampton Road, Flyford Flavell
    WR7 4BT Worcester
    Worcestershire
    British1439590004
    TAYLOR, David
    The Old Rectory
    Bishampton Road, Flyford Flavell
    WR7 4BT Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Bishampton Road, Flyford Flavell
    WR7 4BT Worcester
    Worcestershire
    British1439590004
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish180239190001
    HP DIRECTORS LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore delegato nominato
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    900002660001

    Chi sono le persone con controllo significativo di 9K GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Daisy It Group Limited
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    06 apr 2016
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006 - England And Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    9K GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 giu 2003
    Consegnato il 10 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 10 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 dic 1999
    Consegnato il 06 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0