TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED

TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03887776
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED?

    • (6603) /

    Dove si trova TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Towergate House Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Kent
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL INDEMNITY LIMITED02 dic 199902 dic 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr Samuel Thomas Budgen Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Hunter come segretario

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Andrew Stewart Hunter come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Darryl Clark come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2010

    Stato del capitale al 17 dic 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Timothy Craton come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Darryl Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Timothy Charles Craton il 17 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Geoffrey Cullum il 17 dic 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Antony Proverbs come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    161873090001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandBritish59873490009
    PHILIP, Timothy Duncan
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish99066410001
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Segretario
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    153024670001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Segretario
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    British76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Segretario
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    British99424380001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    156619050001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Segretario
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Amministratore
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    British60697560014
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Amministratore
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritish99424380001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    Amministratore
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritish79185700012
    WHISKIN, Grant Morley
    16 Saxon Road
    Worth
    RH10 7SB Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    16 Saxon Road
    Worth
    RH10 7SB Crawley
    West Sussex
    British44332370001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    TOWERGATE LEGAL AND PROFESSIONAL UNDERWRITING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 ago 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 07 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transazioni
    • 07 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0