PALADIN GROUP LIMITED

PALADIN GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPALADIN GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03899759
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PALADIN GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PALADIN GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PALADIN GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOUCHSTONE ASSET MANAGEMENT LIMITED07 apr 200507 apr 2005
    INVESTIGATE LIMITED17 feb 200017 feb 2000
    OVAL (1487) LIMITED24 dic 199924 dic 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di PALADIN GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PALADIN GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PALADIN GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Indirizzo della sede legale modificato da * 305 Grays Inn Road London WC1X 8QR* in data 17 apr 2014

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2013

    Stato del capitale al 27 nov 2013

    • Capitale: GBP 3,948.5
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    24 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Christopher Martin come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Cowans come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Palframan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roxburgh Milkins Llp come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Martin Green come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2 Crescent Office Park Clarks Way Bath BA2 2AF* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012

    54 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 02 set 2011

    • Capitale: GBP 3,938.60
    8 pagineSH06

    Scissione delle azioni al 22 ago 2011

    9 pagineSH02

    Risoluzioni

    Resolutions
    44 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sub div 22/08/2011
    RES13
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    12 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Chi sono gli amministratori di PALADIN GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Christopher
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Segretario
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    175450390001
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritish108543490005
    HUNT, Matthew William
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2 Crescent Office Park
    Amministratore
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2 Crescent Office Park
    EnglandBritish96479050001
    MIDGLEY, John Philip
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritish66732700002
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish46176700002
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritish47952140001
    SAUNDERS, Diana
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Segretario
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British68743260001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Segretario
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Roxburgh Milkins Llp Merchants
    House North Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Segretario
    Roxburgh Milkins Llp Merchants
    House North Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    ALLATT, Jonathan
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    Amministratore
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    United KingdomBritish165674160002
    BARTON, Simon Edward
    5 Apsley Road
    Newbridge
    BA1 3LP Bath
    Avon
    Amministratore
    5 Apsley Road
    Newbridge
    BA1 3LP Bath
    Avon
    United KingdomBritish103943150001
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Amministratore
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritish76512840002
    CLARK, Jonathan
    34 Church Lane
    Wingfield
    BA14 9LW Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    34 Church Lane
    Wingfield
    BA14 9LW Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish103943140001
    GREEN, Martin Ian
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Amministratore
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    EnglandBritish79471040002
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Amministratore
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritish87647990001
    HUNT, Matthew William
    Roseneath
    Sharpston Freshford
    BA2 7UA Bath
    Somerset
    Amministratore
    Roseneath
    Sharpston Freshford
    BA2 7UA Bath
    Somerset
    EnglandBritish96479050001
    JARRETT, Mark Stephen
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Amministratore
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritish147254950001
    PALFRAMAN, Peter
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Amministratore
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    United KingdomBritish46419220001
    TIDY, Thomas Peter
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    Amministratore
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    United KingdomBritish141619610001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    PALADIN GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 giu 2011
    Consegnato il 15 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 feb 2008
    Consegnato il 20 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 20 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over cash deposit
    Creato il 13 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 05 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured john p midgley, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683023 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 05 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured neil g hollingworth, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number C11006687024 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 05 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured timothy saunders, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683064 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 17 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transazioni
    • 17 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over cash deposit
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 17 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transazioni
    • 17 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:john p midgley, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683023, sum assured:£250,000.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:timothy saunders, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683064, sum assured:£250,000.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:neil g hollingworth, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:C11006684195, sum assured (exclusive of bonuses):£250,000.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over cash deposit
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge, all the rights, title interest and benefit in the deposit and in the deposit account meaning, sort code 401413, account number 82210932. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 30 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Venture Managers Limited
    Transazioni
    • 30 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 06 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    750 touchstone asset management limited "a" ordinary full paid shares of £1 each and all other stocks shares bonds etc together with dividends interest or other distributions.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 29 giu 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee pursuant to the instrument
    Brevi particolari
    First fixed charge the shares and derivative assets (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jss Pinnacle Group Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0