INTEROUTE VTESSE LIMITED

INTEROUTE VTESSE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTEROUTE VTESSE LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 03900836
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o INTEROUTE COMMUNICATIONS LIMITED
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VTESSE NETWORKS LIMITED23 lug 200123 lug 2001
    THE VITESSE PROJECT LIMITED29 dic 199929 dic 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 pagineMISC

    Varie

    Copy of order for completion of merger
    2 pagineMISC

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Varie

    CB01 - notice of a cross border merger
    96 pagineMISC

    Iscrizione dell'ipoteca 039008360009, creata il 15 ago 2018

    72 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 039008360008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039008360006 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039008360007 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Jessica Anne Kaman come amministratore in data 31 mag 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Karl Wright come amministratore in data 31 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gareth John Williams come amministratore in data 31 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Catherine Birkett come amministratore in data 31 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Michael Thomas Sicoli come amministratore in data 31 mag 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Christopher Turing Mckee come amministratore in data 31 mag 2018

    2 pagineAP01

    Varie

    CB01 draft terms of merger
    78 pagineMISC

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 039008360008, creata il 09 ott 2017

    37 pagineMR01

    Cessazione della carica di Philip Howard Grannum come amministratore in data 13 ott 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Catherine Birkett il 02 ott 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    33 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Philip Howard Grannum come amministratore in data 29 nov 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Allan Shearing come amministratore in data 15 nov 2016

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 039008360007, creata il 14 nov 2016

    41 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    34 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KAMAN, Jessica Anne
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    United StatesAmerican247161660001
    MCKEE, Christopher Turing
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    United StatesAmerican161500200001
    SICOLI, Michael Thomas
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    United StatesAmerican246929820001
    PAUL, Lynne Elizabeth
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Segretario
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    158415000001
    PAUL, Lynne Elizabeth
    12 Saint Stephens Avenue
    AL3 4AD St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    12 Saint Stephens Avenue
    AL3 4AD St. Albans
    Hertfordshire
    British67985760001
    TINNER, Richard
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Segretario
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    British51011370001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    BATES, Harry
    84 Ormond Avenue
    TW12 2RX Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    84 Ormond Avenue
    TW12 2RX Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish61296370001
    BIRKETT, Catherine
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    EnglandBritish201977420002
    GIFFORD, Patrick Antony Francis
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish38029990001
    GIFFORD, Patrick Antony Francis
    250 Randolph Avenue
    W9 1PF London
    Amministratore
    250 Randolph Avenue
    W9 1PF London
    United KingdomBritish38029990001
    GRANNUM, Philip Howard
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    EnglandBritish155095270001
    GRANT, David Paul
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish116895380001
    LODGE, Robin Wilfred Ian
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    SwitzerlandBritish154369990002
    MATTHEWS, Andrew Raymond
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50435380001
    PAUL, Aidan Richard
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Amministratore
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United KingdomBritish43770750001
    SAVILLE, Jonathan Michael
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Vtesse Networks Limited
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Vtesse Networks Limited
    Herts
    United Kingdom
    EnglandBritish172596220002
    SHEARING, John Allan
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    BelgiumBritish191514220001
    TARRANT, Peter John
    86 Central Avenue
    Los Gatos
    Califoria
    95030
    Usa
    Amministratore
    86 Central Avenue
    Los Gatos
    Califoria
    95030
    Usa
    British74270440002
    TINNER, Richard
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Amministratore
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United KingdomBritish51011370001
    TODD, Leo Anthony
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish43885620002
    TOONE, Christopher
    Willow Cottage Ferry Lane
    Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Willow Cottage Ferry Lane
    Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish42151270001
    TWITE, Alan Robert
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish74270670001
    TWITE, Alan Robert
    Barton Grange
    IP31 2QX East Barton
    Suffolk
    Amministratore
    Barton Grange
    IP31 2QX East Barton
    Suffolk
    EnglandBritish74270670001
    WICKHAM, David Ian
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    John Tate Road
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    John Tate Road
    Herts
    United Kingdom
    EnglandBritish68123400001
    WILLIAMS, Gareth John
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    United KingdomBritish126668950001
    WRIGHT, Jonathan Karl
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    Amministratore
    c/o Interoute Communications Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    25
    England
    EnglandBritish191515300001
    ZIEMNIAK, Czeslaw Wladyslaw John
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    John Tate Road
    Foxholes Business Park
    SG13 7DT Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish79067460002
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INTEROUTE VTESSE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    06 apr 2016
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione04472687
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    INTEROUTE VTESSE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 ago 2018
    Consegnato il 24 ago 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Keybank National Association, as Administrative Agent (As Security Trustee for the Secured Parties).
    Transazioni
    • 24 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2017
    Consegnato il 19 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 nov 2016
    Consegnato il 17 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 17 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 ott 2015
    Consegnato il 19 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 apr 2015
    Consegnato il 17 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Security Trustee of Rthe Finance Parties
    Transazioni
    • 17 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2014
    Consegnato il 13 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit
    Creato il 01 apr 2008
    Consegnato il 22 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    £70,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge interest in the separate designated interest bearing deposit account into which the deposit is from time to time paid and all monies from time to time standing to the credit of such account and all money from time to time withdrawn from the account. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Datelink Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 set 2007
    Consegnato il 04 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Formerly K/a the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transazioni
    • 04 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 lug 2001
    Consegnato il 28 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 8 july 1997 (as defined)
    Brevi particolari
    Deposit of £76,081.25 in an interest bearing account.
    Persone aventi diritto
    • Matthew Clark Wholesale Bond Limited
    Transazioni
    • 28 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0