R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED

R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03900915
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED?

    • Estrazione di petrolio greggio (06100) / Attività estrattive

    Dove si trova R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Chamberlain Square Cs
    B3 3AX Birmingham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2022

    7 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Alexis Anne Hay il 01 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Campbell Mitchell Meldrum il 01 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ross Martin il 01 mar 2020

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cornwall Court 19 Cornwall Street Birmingham United Kingdom B3 2DT a 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX in data 21 feb 2020

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 gen 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce special reserve 23/12/2019
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Wfw Legal Services Limited come segretario in data 15 ott 2019

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Appold Street London EC2A 2HB a Cornwall Court 19 Cornwall Street Birmingham United Kingdom B3 2DT in data 23 ott 2019

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAY, Alexis Anne
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Aberdeen
    Prime View
    Scotland
    Amministratore
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Aberdeen
    Prime View
    Scotland
    ScotlandBritish243346130001
    MARTIN, Ross
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Aberdeen
    Prime View
    Scotland
    Amministratore
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Aberdeen
    Prime View
    Scotland
    ScotlandBritish166940180001
    MELDRUM, Colin Campbell Mitchell
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Aberdeen
    Prime View
    Scotland
    Amministratore
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Aberdeen
    Prime View
    Scotland
    ScotlandBritish190331680001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    FAIRWEATHER, Colin
    31 Canmore Park
    AB39 2WH Stonehaven
    Kincardineshire
    Segretario
    31 Canmore Park
    AB39 2WH Stonehaven
    Kincardineshire
    British68455160001
    HILLIN, Wayne
    13414 Sweet Surrender Ct
    Houston
    77041
    Texas Usa
    Segretario
    13414 Sweet Surrender Ct
    Houston
    77041
    Texas Usa
    Us American68455080001
    JONES, Roger Shelley
    70 Angusfield Avenue
    AB15 6AT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    70 Angusfield Avenue
    AB15 6AT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British74071600001
    PEARCE, Bill
    9106 Covent Garden
    Houston
    77031-3018
    Texas Us
    Segretario
    9106 Covent Garden
    Houston
    77031-3018
    Texas Us
    Us American68454930001
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    United Kingdom
    Segretario
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01648390
    18093320001
    BAKONYI, Andras
    38 Sandalwood Drive
    Houston
    Tx 77024
    Usa
    Amministratore
    38 Sandalwood Drive
    Houston
    Tx 77024
    Usa
    Australian40682390002
    CAMERON, Barry Nicholas
    Huntly Street
    AB10 1SH Aberdeen
    Langlands House
    United Kingdom
    Amministratore
    Huntly Street
    AB10 1SH Aberdeen
    Langlands House
    United Kingdom
    ScotlandBritish56449460004
    CLYNE, Neil Kenneth
    Kingswells Causeway, Prime Four Business Park
    Kingswells
    AB15 8PU Aberdeen
    Deepwater House
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingswells Causeway, Prime Four Business Park
    Kingswells
    AB15 8PU Aberdeen
    Deepwater House
    United Kingdom
    United KingdomBritish164985600001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Amministratore
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    EVANS, Anthony David
    1 Grove Park
    Camberwell
    SE5 8LT London
    Amministratore
    1 Grove Park
    Camberwell
    SE5 8LT London
    British67650030001
    FAIRWEATHER, Colin
    31 Canmore Park
    AB39 2WH Stonehaven
    Kincardineshire
    Amministratore
    31 Canmore Park
    AB39 2WH Stonehaven
    Kincardineshire
    British68455160001
    HALKETT, Douglas William
    10 Queens Grove
    AB15 8HE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    10 Queens Grove
    AB15 8HE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    British95348400002
    HALKETT, Douglas William
    Newpark House
    Kingswells
    AB15 8PQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Newpark House
    Kingswells
    AB15 8PQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British68455240001
    JONES, Roger Shelley
    Huntly Street
    AB10 1SH Aberdeen
    Langlands House
    Amministratore
    Huntly Street
    AB10 1SH Aberdeen
    Langlands House
    ScotlandBritish74071600001
    KING, Paul Arthur
    Huntly Street
    AB10 1SH Aberdeen
    Langlands House
    United Kingdom
    Amministratore
    Huntly Street
    AB10 1SH Aberdeen
    Langlands House
    United Kingdom
    ScotlandBritish132951950004
    MCEWEN, David
    12 Campsie Place
    AB15 6HL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    12 Campsie Place
    AB15 6HL Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish36334220001
    MOWAT, John Tough
    9 Seafield Drive West
    AB15 7XA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    9 Seafield Drive West
    AB15 7XA Aberdeen
    Aberdeenshire
    British55612910001
    MUNRO, Donald
    3 Cliff House
    Craigton Road, Cults
    AB15 9PS Aberdeen
    Amministratore
    3 Cliff House
    Craigton Road, Cults
    AB15 9PS Aberdeen
    British78979030001
    NESS, Christopher Leonard
    36 Hazledene Road
    AB15 8LD Aberdeen
    Amministratore
    36 Hazledene Road
    AB15 8LD Aberdeen
    ScotlandBritish82383670004
    ROSE, Adrian Paul
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Kingswells
    Deepwater House
    Aberdeen
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Kingswells
    Deepwater House
    Aberdeen
    United Kingdom
    ScotlandBritish163505080001
    URE, Graeme John Robert
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Kingswells
    Deepwater House
    Aberdeen
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingswells Causeway
    Prime Four Business Park
    AB15 8PU Kingswells
    Deepwater House
    Aberdeen
    United Kingdom
    ScotlandBritish89300220001
    WALLS, David Michael
    Kingswells Causeway, Prime Four Business Park
    Kingswells
    AB15 8PU Aberdeen
    Deepwater House
    Scotland
    Amministratore
    Kingswells Causeway, Prime Four Business Park
    Kingswells
    AB15 8PU Aberdeen
    Deepwater House
    Scotland
    ScotlandBritish207736150001
    WITTE, Cornelis Adrianus
    Monearn
    Maryculter
    AB12 5GT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Monearn
    Maryculter
    AB12 5GT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Dutch74071540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Transocean Ltd.
    Turmstrasse
    CH 6300 Zug
    30
    Steinhausen
    Switzerland
    06 apr 2016
    Turmstrasse
    CH 6300 Zug
    30
    Steinhausen
    Switzerland
    No
    Forma giuridicaPublic Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneSwitzerland
    Autorità legaleSwiss Law
    Luogo di registrazioneCommercial Register Of The Canton Of Zug
    Numero di registrazioneChe-114.461.224
    Cerca nel registro di commercio svizzero (Zefix)Transocean Ltd.
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental fixed and floating security document
    Creato il 15 mag 2003
    Consegnato il 22 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all its additional rights and interest, its opriginal rights and interest. By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank (The Trustee)
    Transazioni
    • 22 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second supplemental indenture and amendment between rbf exploration co., (The "issuer") btm capital corporation (the "owner") nautilus exploration limited (the "standby purchaser") r&b falcon deepwater (UK) limited (the "lessee") and chase bank of texas national association as trustee (the "trustee")
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 21 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The prompt and complete payment of the project indebtedness (as defined) and the performance of the covenants contained in the indenture and in all other project deocuments (as defined) the ("secured obligations").
    Brevi particolari
    All equipment inventory fixtures and other goods (including without limitation the drilling RIG0 in all forms whereverlocated and whether now or hereafter existing which are owned by the lessee or in which the lessee otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Bank of Texas
    Transazioni
    • 21 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of drilling contract made by the assignor (the company) to chase bank of texas national association (together with its successors and assigns, the "assignee") as trustee under a trust indenture and security agreement dated 12 august 1999 (as amended and supplemented)
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 21 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations secured by the trust indenture and the other project documents
    Brevi particolari
    The assignor grants sells conveys assigns transfer sets over mortgages and pledges to the assignee and unto the assignee's successors and assigns all its right title interest claim and demand. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Bank of Texas
    Transazioni
    • 21 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security docment mad ebetween the lessee (the company) and chase bank of texas, national association (the "trustee")
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 21 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The prompt and complete payment of the project indebtedess (as defined) and the performance of the covenants contained in the trust indenture and security agreement dated 12 august 1999 as subsequently amended and supplemented
    Brevi particolari
    By way of a fixed charge, charges and assigns in favour of the trustee all its rights and interest in and to the lessee trust estate together with to the extent not part of the lessee trust estate the lessee documents and the by way of floating charge charges in favour of the trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Bank of Texas
    Transazioni
    • 21 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement - pledge
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 07 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a! A lease agreement dated 2 june 2000 b! Security agreement - pledge and c! Any security documents under such a lease agreement
    Brevi particolari
    The company's right title and interest and to all general intangibles in connection with the rights of the company and in connection with an account with chase bank of texas national association account number 55-03-001-2074900.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Corporate Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An account assignment
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 07 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a! A lease agreement dated 2 june 2000 b! A lease accounts assignment and c! Any other documents executed under such a lease agreement
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the sterling account designated "r & b falcon deepwater õuk! Limited lessee account" account number 1697196.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Corporate Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    R & B FALCON DEEPWATER (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 set 2021Inizio della liquidazione
    12 apr 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0