STERLING WEST POINT LIMITED

STERLING WEST POINT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTERLING WEST POINT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03902736
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STERLING WEST POINT LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova STERLING WEST POINT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Mazars Llp The Lexicon
    Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STERLING WEST POINT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STERLING SCARBOROUGH LIMITED23 giu 200323 giu 2003
    STERLING TEESLAND LIMITED05 giu 200005 giu 2000
    MAJORBONUS LIMITED05 gen 200005 gen 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di STERLING WEST POINT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per STERLING WEST POINT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ in data 04 ott 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 set 2012

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 gen 2012

    Stato del capitale al 09 gen 2012

    • Capitale: GBP 404,881
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2011

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 14 lug 2011

    3 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 05 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Simon Charles Mccabe come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Richardson come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 28 feb 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 19 nov 2010

    3 pagineCH01

    Nomina di Mr Paul Richardson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Mccabe come amministratore

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 nov 2010

    • Capitale: GBP 404,881.00
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    To remove any limit imposed on share capital 17/11/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 28 feb 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Esplanade Director Limited il 05 gen 2010

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Esplanade Secretarial Services Limited il 05 gen 2010

    2 pagineCH04

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di STERLING WEST POINT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6133270
    123430250001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6133267
    123430390001
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Segretario
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Segretario
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ARMSTRONG, Michael Lars
    Gateshill
    Ripley Road
    HG5 9HA Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gateshill
    Ripley Road
    HG5 9HA Knaresborough
    North Yorkshire
    British76125250001
    ARMSTRONG, Michael Lars
    Gateshill
    Ripley Road
    HG5 9HA Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gateshill
    Ripley Road
    HG5 9HA Knaresborough
    North Yorkshire
    British76125250001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Amministratore
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CROXEN, Martin
    Hillside Court
    Hillway Guiseley
    LS20 8HU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hillside Court
    Hillway Guiseley
    LS20 8HU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish5134770003
    DALZELL, Christopher John
    1 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    Amministratore
    1 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    British9520500002
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish141515870001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    MURRAY, Robert Sydney
    Crayke Court Church Hill
    Crayke
    YO6 4TA York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crayke Court Church Hill
    Crayke
    YO6 4TA York
    North Yorkshire
    British4706200002
    OLIVER, Paul Francis
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    Amministratore
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    British14735150001
    RICHARDSON, Paul
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish133683730001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Rachel Elizabeth
    Betchworth House
    101 Westhall Road
    CR6 9HG Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    Betchworth House
    101 Westhall Road
    CR6 9HG Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish96527400001
    ROBERTSON, Rachel Elizabeth
    Betchworth House
    101 Westhall Road
    CR6 9HG Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    Betchworth House
    101 Westhall Road
    CR6 9HG Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish96527400001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    WELLS, David Morrison
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    Amministratore
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    United KingdomBritish89226130001
    WELLS, David Morrison
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    Amministratore
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    United KingdomBritish89226130001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    STERLING WEST POINT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 05 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    STERLING WEST POINT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 gen 2014Data di scioglimento
    13 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tim Alan Askham
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Praticante
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0