EV COMMUNITIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EV COMMUNITIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03904306 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EV COMMUNITIES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova EV COMMUNITIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Lewis Golden Llp 40 Queen Anne Street W1G 9EL London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EV COMMUNITIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LENDLEASE COMMUNITIES LIMITED | 01 lug 2016 | 01 lug 2016 |
| LEND LEASE COMMUNITIES LIMITED | 24 giu 2005 | 24 giu 2005 |
| LEND LEASE URBAN REGENERATION LIMITED | 17 apr 2002 | 17 apr 2002 |
| OVERGATE FEEDER GP LIMITED | 25 gen 2000 | 25 gen 2000 |
| HACKREMCO (NO.1601) LIMITED | 11 gen 2000 | 11 gen 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EV COMMUNITIES LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per EV COMMUNITIES LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 11 feb 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 25 feb 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 11 feb 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per EV COMMUNITIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2025 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Paul Jessup il 13 gen 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2024 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2023 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 giu 2021 al 31 mar 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 29 giu 2020 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2020 al 29 giu 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Paul Jessup il 26 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Paul Jessup il 26 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Elliot Stephen Lipton il 26 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Elliot Stephen Lipton il 17 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Paul Jessup il 17 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Barry Paul Jessup come amministratore in data 17 giu 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione di Lendlease Europe Retail Investments Limited come persona con controllo significativo il 17 giu 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Kempal Homes Limited come persona con controllo significativo il 17 giu 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 20 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF a C/O Lewis Golden Llp 40 Queen Anne Street London W1G 9EL in data 19 giu 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EV COMMUNITIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSUP, Barry Paul | Amministratore | 40 Queen Anne Street W1G 9EL London C/O Lewis Golden Llp England | United Kingdom | British | 158351360005 | |||||||||
| LIPTON, Elliot Stephen | Amministratore | 40 Queen Anne Street W1G 9EL London C/O Lewis Golden Llp England | United Kingdom | British | 270990680002 | |||||||||
| CUTTS, Alistair | Segretario | 15a Vine Road KT8 9LF East Molesey Surrey | British | 103721920002 | ||||||||||
| DAVIDSON, Patricia Margaret | Segretario | 39 Saunderton Vale Saunderton HP14 4LJ High Wycombe Buckinghamshire | British | 38824170008 | ||||||||||
| JANANDRAN, Thanalakshmi | Segretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | British | 93299990001 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Segretario | 36 Vicarage Road RG9 1HW Henley On Thames Oxfordshire | British | 92464400001 | ||||||||||
| NICKLIN, Susan Patricia | Segretario | Flat 4 7 Barkston Gardens SW5 0ER Earls Court London | British | 88285310001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Dukes Place EC3A 7NH London 40 England |
| 102944500001 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| ARTHUR, Derryn Sue | Amministratore | 21 Elsham Road W14 8HA London | New Zealander | 57726590002 | ||||||||||
| CAVEN, Robin Graham | Amministratore | 74 St Johns Road TN13 3NB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 76216840002 | |||||||||
| CLARK, John David | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 224239010001 | |||||||||
| COCKBURN, George Ian Macloy | Amministratore | 9 High Meadow Close RH4 2LG Dorking Surrey | England | British | 58892420002 | |||||||||
| COOK, Richard John | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 178588500002 | |||||||||
| DAVIES, Justin | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | Australian | 247518540002 | |||||||||
| DICKINSON, Mark Davies | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 267657020001 | |||||||||
| EMERY, Jonathan Michael | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 223799670001 | |||||||||
| GOUGH, Alison Louise | Amministratore | Flat 1 15 Southwood Avenue N6 5RY London | British | 62074540002 | ||||||||||
| HUGILL, William Nigel | Amministratore | 15 Briar Walk Putney SW15 6UD London | England | British | 3015960006 | |||||||||
| LABBAD, Daniel | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | Australian | 111679880003 | |||||||||
| MARTIN, Herbert William | Amministratore | 10 Plummets Croft Dunton Green TN13 2TZ Sevenoaks Kent | British | 79853480001 | ||||||||||
| O'ROURKE, Benjamin Michael | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | United Kingdom | Australian | 156924720001 | |||||||||
| PERRY, David Keith | Amministratore | Saint Leonards Road KT6 4DE Surbiton 10 Surrey | England | British | 71558970002 | |||||||||
| PETTETT, Claire Marianne | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 337511320001 | |||||||||
| POWELL, Richard Ian | Amministratore | 103a Grandison Road SW11 6LT London | British | 94174880002 | ||||||||||
| QUINLAN, Victoria Elizabeth | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | Australian | 134667530006 | |||||||||
| RAMPTON, Andrew | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 183435140001 | |||||||||
| REAY, David Browell | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 93842970004 | |||||||||
| REAY, David Browell | Amministratore | 3 Limewood Close W13 8HL London | England | British | 93842970002 | |||||||||
| SCOTT, Georgina Jane | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 129107550001 | |||||||||
| SCOTT, Georgina Jane | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 129107550001 | |||||||||
| SEELEY, Rebecca Jayne | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | United Kingdom | British | 217722670001 | |||||||||
| TAYLOR, Matthew | Amministratore | 95 Solon Road SW2 5UX Lambeth London | British | 123340130001 | ||||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EV COMMUNITIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kempal Homes Limited | 17 giu 2020 | Queen Anne Street W1G 9EL London 40 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Lendlease Europe Retail Investments Limited | 06 apr 2016 | Regent's Place NW1 3BF London 20 Triton Street England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0