JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED

JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03907029
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    • Assicurazioni sulla vita (65110) / Attività finanziarie e assicurative
    • Riassicurazione vita (65201) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Trinity House Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOHN SIDDALL ASSET MANAGEMENT LIMITED14 gen 200014 gen 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineAA03

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Rupert Norcliffe Holderness come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Clifford Spencer Jones come segretario in data 07 apr 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di John Anderson Scotland Watson come amministratore in data 07 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Anderson Scotland Watson come segretario in data 07 apr 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 feb 2015

    Stato del capitale al 25 feb 2015

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2014

    Stato del capitale al 15 gen 2014

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AL England* in data 25 nov 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facilities agreement/transactions approved 12/05/2011
    RES13
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Clifford Spencer Jones come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di George Simms come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    legacy

    22 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Clifford Spencer
    Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Trinity House
    Segretario
    Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Trinity House
    196543500001
    JONES, Clifford Spencer
    Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Trinity House
    England
    Amministratore
    Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Trinity House
    England
    United KingdomBritishAccountant105862690002
    WALLACE, Sarah Elizabeth
    Brookside Wickham Road
    Curdridge
    SO32 2BA Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Brookside Wickham Road
    Curdridge
    SO32 2BA Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Secretary11659280001
    WATSON, John Anderson Scotland
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant81703720005
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CURD, Walter Brian
    24 Bartlett Close
    PO15 6BQ Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    24 Bartlett Close
    PO15 6BQ Fareham
    Hampshire
    BritishDirector27944250001
    DEELEY, John Inston
    87 Bryher Island
    Port Solent
    PO6 4UF Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    87 Bryher Island
    Port Solent
    PO6 4UF Portsmouth
    Hampshire
    BritishDirector53607410002
    FRY, Jonathan Edward Leighton
    4 Romney Close
    St Ives
    PE27 3HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    4 Romney Close
    St Ives
    PE27 3HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishDirector47278320001
    HOLDERNESS, Rupert Norcliffe
    Villa Des Bois
    39 Avenue Du Bois
    Andernos
    33510
    France
    Amministratore
    Villa Des Bois
    39 Avenue Du Bois
    Andernos
    33510
    France
    FranceBritishDirector86136870001
    SIMMS, George Mervyn
    104 Romsey Road
    SO22 5PJ Winchester
    Amministratore
    104 Romsey Road
    SO22 5PJ Winchester
    United KingdomIrishFinancial Advisor85931600001
    SMITH, Gordon John
    Foxes Path 12 Gainsborough Road
    Ashley Heath
    BH24 2HY Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Foxes Path 12 Gainsborough Road
    Ashley Heath
    BH24 2HY Ringwood
    Hampshire
    BritishIfa105678420001
    STEWART, Martin Alastair
    7 Old Rectory Court
    61 Wood Street
    EN5 4BL Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Old Rectory Court
    61 Wood Street
    EN5 4BL Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director103479180001
    WALLACE, David William Mckinstry
    Brookside Wickham Road
    Curdridge
    SO32 2BA Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Brookside Wickham Road
    Curdridge
    SO32 2BA Southampton
    Hampshire
    BritishDirector2299690001
    WATSON, John Anderson Scotland
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant81703720005
    YOUNG, James Patrick
    126 Spring Road
    Sholing
    SO19 2QB Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    126 Spring Road
    Sholing
    SO19 2QB Southampton
    Hampshire
    BritishAccountant99693170001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    JOHN SIDDALL INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 24 mag 2011
    Consegnato il 08 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 21 nov 2006
    Consegnato il 29 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0