HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED

HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03908294
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAYLEY CONFERENCE CENTRES HOLDINGS LIMITED06 apr 200006 apr 2000
    SJC 77 LIMITED18 gen 200018 gen 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 039082940009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039082940007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039082940008 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 039082940009, creata il 10 ott 2018

    75 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 gen 2016

    Stato del capitale al 20 gen 2016

    • Capitale: GBP 10,720,000
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 039082940008, creata il 01 dic 2015

    85 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 10,720,000
    SH01

    Nomina di Mr James Alexander Burrell come amministratore in data 10 nov 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 039082940007

    91 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mrs Geraldine Josephine Gallagher come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Bennison come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishHuman Resources Director98567690002
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Segretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    161787590001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121230001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Segretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    ROLFE, Richard Mark
    4 Wicket Grove
    Lenton
    NG7 2FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    4 Wicket Grove
    Lenton
    NG7 2FS Nottingham
    Nottinghamshire
    British65467050002
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Secretary45253560008
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    BritishDirector126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    CASTON, Richard Charles Austin
    11 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    11 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishInvestment Manager62682380001
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Amministratore
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritishDirector124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    ENGLISH, Alan Henry
    Manor Farm House
    Church Brampton
    NN6 8AT Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Manor Farm House
    Church Brampton
    NN6 8AT Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector5206190001
    HALL, Wendy Margaret
    37a London Road
    Shardlow
    DE72 2GR Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    37a London Road
    Shardlow
    DE72 2GR Derby
    Derbyshire
    BritishSolicitor75667340001
    HEYWOOD, Ivan Maxwell
    The Old Parsonage
    The Street Long Sutton
    RG29 1SS Hook
    Hampshire
    Amministratore
    The Old Parsonage
    The Street Long Sutton
    RG29 1SS Hook
    Hampshire
    BritishInvestment Manager57119520002
    LITTLEWOOD, Jane Alison
    5 Shenhurst Close
    SK9 6NB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Shenhurst Close
    SK9 6NB Wilmslow
    Cheshire
    BritishSales Manager50102790004
    NICOLL, Brenda Jane
    Corner Barn Howton Grove
    Wormbridge
    HR2 9DY Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Corner Barn Howton Grove
    Wormbridge
    HR2 9DY Hereford
    Herefordshire
    BritishGeneral Manager50102710002
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director132613500001
    PARFREY, Joanne
    2 Merivale Road
    Putney
    SW15 2NW London
    Amministratore
    2 Merivale Road
    Putney
    SW15 2NW London
    BritishInvestment Manager93310210001
    ROLFE, Richard Mark
    4 Wicket Grove
    Lenton
    NG7 2FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    4 Wicket Grove
    Lenton
    NG7 2FS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishSolicitor65467050002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hayley Conference Centres Acquisitions Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 apr 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione05576842
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HAYLEY CONFERENCE CENTRES GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2018
    Consegnato il 11 ott 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transazioni
    • 11 ott 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 dic 2015
    Consegnato il 03 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 03 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2014
    Consegnato il 18 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 18 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    English law deed of accession
    Creato il 27 feb 2013
    Consegnato il 01 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 01 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2011
    Consegnato il 10 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 18 giu 2007
    Consegnato il 22 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 mar 2006
    Consegnato il 06 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    Transazioni
    • 06 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2000
    Consegnato il 18 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0