EVANS (ASHFORD) LIMITED

EVANS (ASHFORD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVANS (ASHFORD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03911592
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EVANS EASYSPACE LIMITED21 gen 200021 gen 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 14 nov 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Robert Marshall come amministratore in data 01 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Matthew Syers come amministratore in data 01 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Terence Millington come amministratore in data 01 lug 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    21 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Matthew Syers il 22 nov 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Terence Millington il 22 nov 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2016

    Stato del capitale al 23 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARSHALL, Robert
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Segretario
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    165897290001
    EVANS, Roderick Michael
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Amministratore
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director40175270005
    MARSHALL, Robert
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Amministratore
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant190577840001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    BELL, John Drummond
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    North Yorkshire
    Amministratore
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector63940900003
    COOPER, Bradley
    2 Rufford Drive
    LS19 7QZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Rufford Drive
    LS19 7QZ Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant94039480001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishDirector84076630001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant81344240001
    MARCUS, Ian
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Amministratore
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director85847920002
    MILLINGTON, Paul Terence
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Amministratore
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant58693930003
    STOKES, Thomas Mcnair
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishCompany Director854380001
    SYERS, Alan Matthew
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    Amministratore
    Millshaw
    Leeds
    LS11 8EG West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor65588650002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EVANS (ASHFORD) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    06 apr 2016
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06006477
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EVANS (ASHFORD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 2007
    Consegnato il 27 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of feltham road ashford t/h t/n SY479887 together with all buildings fixtures and fittings (excluding in the case of l/h property, landlords fixtures but including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery from time to time therein and the proceeds of sale of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 27 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fifth supplemental trust deed
    Creato il 05 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal on £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 issued by evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold land and buildings on south side of feltham rd,ashford,surrey; SY479887; all buildings erections fixtures fittings fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 14 november 2003 and
    Creato il 12 nov 2003
    Consegnato il 27 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole of the company's interests as tenants under the lease dated 5 and 6 november 2003 of the subjects lying to the west of queensferry road, dunfermaline , fife.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 12 november 2003 and
    Creato il 12 nov 2003
    Consegnato il 27 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interests as tenants under a lease dated 2 august and 28 september 1984 t/no STG20463.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to a composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 01 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land together with all buildings and fixtures at any time on the south side of feltham road ashford surrey t/n SY479887. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 giu 2003
    Consegnato il 03 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at deeside industrial estate, deeside, flintshire t/n CYM119810 and/or the proceeds of sale thereof together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Welsh Development Agency
    Transazioni
    • 03 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal mortgage to a composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 31 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h land and buildings k/a deeside industrial estate queensferry flintshire together with all buildings and fixtures at any time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal mortgage (to composite guarantee and debenture dated 27TH may 1999)
    Creato il 22 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries (all terms as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Various properties together with all buildings and fixtures the first three of which are f/h land at boughton industrial estate boughton t/no.NT340444, f/h land and buildings at boughton industrial estate boughton t/no.NT337708, f/h land k/a wem industrial estate and sewage works soulton road wem shropshire t/no.SL119266 see form 395 for further details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registratkion in scotland on 9TH february 2001
    Creato il 29 nov 2000
    Consegnato il 16 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1). 68,70,72 and 74 queen elizabeth avenue hillingdon industrial estate renfrew REN302267 2). 53-58 south avenue blantyre LAN36299 3). gpt factory mitchelson drive kirkaldy FFE42814 4). inchinnan road bellshill industrial estate bellshill LAN91966 5). earl road grangemouth STG20463.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 20 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings k/a milthorp business centre monckton road wakefield t/n WYK18560 and WYK329582 together with all fixtures thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creato il 27 lug 2000
    Consegnato il 05 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) to any of the beneficiaries (as defined) under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries(As Defined)
    Transazioni
    • 05 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0