KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED

KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03920625
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Updown Court
    Chertsey Road
    GU20 6HY Windlesham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TEESMARTIN PROPERTIES LIMITED28 apr 200028 apr 2000
    CITYFRONT LIMITED07 feb 200007 feb 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 giu 2014

    9 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    600

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:ordinary resolution ;- "books, records.etc"
    2 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    2 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 feb 2011

    Stato del capitale al 21 feb 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2010 al 31 ott 2010

    1 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    29 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Gordon Bennet come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * the 6Th Floor Coin House 2 Gees Court London W1U 1JA* in data 18 mar 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2009

    12 pagineAA

    Nomina di Gordon Iain Bennet come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Susan Elizabeth Groat come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    Amministratore
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    ScotlandBritishProperty Developer88980540001
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    24 Littlefield Close
    Nether Poppleton
    YO2 6HX York
    North Yorkshire
    Segretario
    24 Littlefield Close
    Nether Poppleton
    YO2 6HX York
    North Yorkshire
    British56953000001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Segretario
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    BritishFinance Director83466350002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Segretario
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    ZAJAC, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320002
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Segretario
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Amministratore
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    United KingdomBritishChartered Accountant60009740002
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Amministratore
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritishQuantity Surveyor35543830001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishManager141515870001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Amministratore
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    ScotlandBritishFinance Director83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Amministratore
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    BritishProperty97869190001
    OLIVER, Paul Francis
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    Amministratore
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    BritishManaging Director14735150001
    PECK, David Howard
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    Amministratore
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    BritishChartered Surveyor48939900005
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritishChartered Surveyor161858620001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 20 apr 2007
    Consegnato il 02 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 07 ott 2003
    Consegnato il 17 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee (whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the present and future right title and interest of that chargor in and to all the charged securities which are at any time owned by that chargor or in which that chargor from time to time has an interest together with all related rights from time to time occurring to those charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 mar 2002
    Consegnato il 09 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 giu 2011Inizio della liquidazione
    17 lug 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Praticante
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Timothy Gerard Walsh
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Praticante
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0