VC WORLD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVC WORLD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03920909
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VC WORLD LIMITED?

    • Attività di telecomunicazioni cablate (61100) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova VC WORLD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VC WORLD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per VC WORLD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 set 2016

    11 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 lug 2016

    12 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Europe House Windmill Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7HB a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 21 lug 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 lug 2015

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 lug 2014

    Stato del capitale al 24 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 25 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 24/06/2014
    RES13

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Simon Porter come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Simon Porter come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Allen come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 04 lug 2012

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VC WORLD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLEN, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish182527790001
    COOK, Edward Charles Peregrine Phelps
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish52906920005
    MORGAN, Anthony
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    British99904380001
    PORTER, Simon Neil
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    159312480001
    SELBY, Daniel
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    Segretario
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    British51588390003
    SOMERS, Harold Arnold
    57 Berrylands Road
    KT5 8PB Surbiton
    Surrey
    Segretario
    57 Berrylands Road
    KT5 8PB Surbiton
    Surrey
    British34828300001
    APEX COMPANY SERVICES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Segretario nominato
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004340001
    REYNOLDS PORTER CHAMBERLAIN
    Chichester House
    278-282 High Holborn
    WC1V 7HA London
    Segretario
    Chichester House
    278-282 High Holborn
    WC1V 7HA London
    4427140001
    CAVE, Terrence William
    32 Carroll Avenue
    BH22 8BP Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    32 Carroll Avenue
    BH22 8BP Ferndown
    Dorset
    EnglandEnglish73014640001
    KNOX, Frederick Samuel, Mr.
    32 Fitzroy Road
    NW1 8TY London
    Amministratore
    32 Fitzroy Road
    NW1 8TY London
    United KingdomBritish125723370002
    MACFARLANE, Bruce Ferguson
    5 Inkerman Terrace
    Allen Street
    W8 6QX London
    Amministratore
    5 Inkerman Terrace
    Allen Street
    W8 6QX London
    EnglandBritish55760240001
    MACPHERSON, Alexander Blake
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish51955440001
    MORGAN, Anthony
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    British99904380001
    NOVELLI, George Albert
    18 Crofters Close
    GU16 6GH Deepcut
    Surrey
    Amministratore
    18 Crofters Close
    GU16 6GH Deepcut
    Surrey
    British74182160005
    PORTER, Simon Neil
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandUnited Kingdom55262300006
    SELBY, Daniel
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    Amministratore
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    United KingdomBritish51588390003
    SOMERS, Daniel Peter
    Flat 1 129 Saint Georges Road
    SE1 6HY London
    Amministratore
    Flat 1 129 Saint Georges Road
    SE1 6HY London
    EnglandBritish67888460003
    STERE, James
    2 Chainhurst Farm Cottages
    Hunton Road
    TN12 9TA Chainhurst
    Kent
    Amministratore
    2 Chainhurst Farm Cottages
    Hunton Road
    TN12 9TA Chainhurst
    Kent
    United KingdomBritish124241250001
    WADE, Christopher John
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish61432110001
    APEX NOMINEES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Amministratore delegato nominato
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004330001

    VC WORLD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 04 lug 2012
    Consegnato il 11 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor or any of them to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital V Sarl (The Chargee)
    Transazioni
    • 11 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 06 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 apr 2007
    Consegnato il 03 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,795.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Cash deposit made pursuant to the said rent deposit deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davy Property Holdings Limited, B.J. Walsh and F.M. O'donovan T/a Owm Properties
    Transazioni
    • 03 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 dic 2004
    Consegnato il 31 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all f/h and l/h property, all fixtures and fittings, all plant machinery and other equipment, all goodwill unpaid and/or uncalled capital, all intellectual property, all securities, all loan capital, all amounts realised and non-vesting debts. Floating charge on all other debts and the property assets and rights and on the remainder of the undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 31 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 44632363 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all rights, title, interest and benefit in all sums from time to time due under all sale or supply contracts.
    Persone aventi diritto
    • Dan Somers and Graham Pay
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 apr 2003
    Consegnato il 14 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    VC WORLD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 lug 2015Inizio della liquidazione
    26 dic 2016Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0