SELECT LIVING (DEVON) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SELECT LIVING (DEVON) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03940629 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Graham House 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Hertfordshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NEW CARE (DEVON) LIMITED | 06 mar 2000 | 06 mar 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 03 apr 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Notifica di Bodmin Energy Limited come persona con controllo significativo il 24 gen 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Ro Select Limited come persona con controllo significativo il 24 gen 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2017 al 30 mar 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hamlyn House Ground Floor Mardle Way Buckfastleigh Devon TQ11 0NS England a Graham House 7 Wyllyotts Place Potters Bar Hertfordshire EN6 2JD in data 14 dic 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 apr 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di David Colin Roberts come amministratore in data 26 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 20 Courtenay Park Newton Abbot Devon TQ12 2HB a Hamlyn House Ground Floor Mardle Way Buckfastleigh Devon TQ11 0NS in data 22 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Susan Margaret Younghusband come amministratore in data 23 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 05 apr 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Shaw come amministratore in data 20 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed new care (devon) LIMITED\certificate issued on 29/09/15 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di James Dominic Gaisford come amministratore in data 22 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Stanley Newcombe come amministratore in data 06 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Graham St John Rowlandson come amministratore in data 22 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 06 apr 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Graham House 7 Wyllyotts Place Potters Bar Hertfordshire EN6 2JD England a 20 Courtenay Park Newton Abbot Devon TQ12 2HB in data 21 ott 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 20 Courtenay Park Newton Abbot Devon TQ12 2HB a Graham House 7 Wyllyotts Place Potters Bar Hertfordshire EN6 2JD in data 13 ott 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Shirley Newcombe come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE FINANCE AND INDUSTRIAL TRUST LIMITED | Segretario | Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House, 7 Hertfordshire United Kingdom |
| 147134030001 | ||||||||||
| ROWLANDSON, Edward Thomas Morton | Amministratore | Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House, 7 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 124370370002 | |||||||||
| NEWCOMBE, Shirley Anne | Segretario | Mamhead View EX8 1DS Exmouth 7 Devon Uk | British | 68636750002 | ||||||||||
| BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon | 900001040001 | |||||||||||
| GAISFORD, James Dominic | Amministratore | Courtenay Park TQ12 2HB Newton Abbot 20 Devon England | United Kingdom | British | 154455640001 | |||||||||
| NEWCOMBE, Gillian Anne | Amministratore | Victoria Road EX8 1DW Exmouth 52 Devon Uk | England | British | 68636740004 | |||||||||
| NEWCOMBE, Richard Stanley | Amministratore | Courtenay Park TQ12 2HB Newton Abbot 20 Devon England | United Kingdom | British | 68636730002 | |||||||||
| NEWCOMBE, Shirley Anne | Amministratore | Courtenay Park TQ12 2HB Newton Abbot 20 Devon | England | British | 154052260001 | |||||||||
| ROBERTS, David Colin | Amministratore | 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House Hertfordshire United Kingdom | England | British | 159964580001 | |||||||||
| ROWLANDSON, Richard Graham St John | Amministratore | Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House, 7 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 3609230001 | |||||||||
| SHAW, Andrew David | Amministratore | Courtenay Park TQ12 2HB Newton Abbot 20 Devon England | England | British | 173096770001 | |||||||||
| YOUNGHUSBAND, Susan Margaret | Amministratore | Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House, 7 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 104413240002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SELECT LIVING (DEVON) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodmin Energy Limited | 24 gen 2018 | Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Ro Select Limited | 06 apr 2016 | 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House Hertfordshire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SELECT LIVING (DEVON) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 20 mar 2000 Consegnato il 24 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 20 mar 2000 Consegnato il 24 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The freehold property known as 118 ashburton road newton abbot devon title number DN92387. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 20 mar 2000 Consegnato il 24 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The freehold property known as 120 ashburton road newton abbot devon title number DN70282. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0