WEIGH-TRONIX UK LIMITED

WEIGH-TRONIX UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWEIGH-TRONIX UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03943960
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di S & J Registrars Limited come segretario in data 30 giu 2021

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Nsc Europe Limited come persona con controllo significativo il 22 mag 2019

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Nsc Europe Limited come persona con controllo significativo il 18 mar 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    25 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Nsc Europe Limited come persona con controllo significativo il 06 mar 2017

    2 paginePSC05

    Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 04 mag 2015

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Rowell il 16 mar 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ryan Ronald Dale come segretario in data 18 dic 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Philip Matthew Deakin come amministratore in data 30 ott 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    24 pagineAA

    Cessazione della carica di Edward Ufland come amministratore in data 13 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 dic 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DALE, Ryan Ronald
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Segretario
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    241475320001
    HUDSON, Giles Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish161583790003
    ROWELL, Stephen James
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish208316380001
    FOGARTY, Robert Joseph
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    Segretario
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    British17437720002
    GUNNING, Laurence Patrick
    Bushey Cottage
    High Street, Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Bushey Cottage
    High Street, Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Irish45213690002
    SIMPSON, Thomas Andrew
    19 Regents Park Terrace
    NW1 7ED London
    Segretario
    19 Regents Park Terrace
    NW1 7ED London
    British67284540001
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Segretario
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione01740543
    132600000001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    BOWE, Gerald Grant
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    Amministratore
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    American86912720003
    CASTLE, David Rayner
    47 Frederick Road
    Edgbaston
    B15 1HN Birmingham
    Amministratore
    47 Frederick Road
    Edgbaston
    B15 1HN Birmingham
    American86859030001
    COOPER, Timothy John
    38 Grosvenor Close
    Four Oaks Sutton Coalfield
    B75 6RP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    38 Grosvenor Close
    Four Oaks Sutton Coalfield
    B75 6RP Birmingham
    West Midlands
    British145948190001
    CRAMER, Carl, Mr.
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    Amministratore
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    United KingdomBritish92710960001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish146225080003
    GUNNING, Laurence Patrick
    Bushey Cottage
    High Street, Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Bushey Cottage
    High Street, Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Irish45213690002
    MCCANN, John J
    141 Blackstone Blvd
    Providence
    R I 02906
    Usa
    Amministratore
    141 Blackstone Blvd
    Providence
    R I 02906
    Usa
    American68980260001
    SIMPSON, Thomas Andrew
    19 Regents Park Terrace
    NW1 7ED London
    Amministratore
    19 Regents Park Terrace
    NW1 7ED London
    British67284540001
    STEPHENS, Daniel Melville
    20 Wroughton Road
    SW11 6BG London
    United Kingdom
    Amministratore
    20 Wroughton Road
    SW11 6BG London
    United Kingdom
    British68742720001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UFLAND, Edward
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    EnglandBritish161583570001
    WILKINSON, Richard
    72 Causey Farm Road
    B63 1EL Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    72 Causey Farm Road
    B63 1EL Halesowen
    West Midlands
    British145948210001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    06 apr 2016
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4554866
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    WEIGH-TRONIX UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 lug 2006
    Consegnato il 21 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • European Capital Financial Services Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 21 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge on registered shares
    Creato il 31 lug 2006
    Consegnato il 18 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company creates first ranking rights of pledge now or as the case may be in advance to the pledgees over, the present shares, the future shares and the rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • European Capital Financial Services Limited (The Pledgee)
    Transazioni
    • 18 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 giu 2005
    Consegnato il 03 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property k/a soho foundry foundry lane smethwick west midlands t/n WM848738.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of agreement and pledge
    Creato il 13 giu 2000
    Consegnato il 04 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and by virtue of the credit agreement (as defined) the security document any specified hedge agreement or any loan document
    Brevi particolari
    The company creates first ranking rights of pledge now or as the case may be in advance to the plegees over, the present shares, the future shares and the rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank, Lehman Commercial Paper Inc, the Provident Bank, Bank of Scotlandfleet National Bank in Its Capacity as Agent, as Fronting Lender, as Issuing Lender and as Swing Line Lender and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 04 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 13 giu 2000
    Consegnato il 20 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future monies and liabilities due or to become due from the company or/any other company named therein to the chargee under or in connection with any loan document or specified hedge agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 20 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0