VAN DEN OUDEN LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVAN DEN OUDEN LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03948176
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VAN DEN OUDEN LTD?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova VAN DEN OUDEN LTD?

    Indirizzo della sede legale
    3 Warren Yard Warren Park
    Stratford Road
    MK12 5NW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VAN DEN OUDEN LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VAN DEN OUDEN LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VAN DEN OUDEN LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Chancery Pavilion Boycott Avenue Oldbrook Milton Keynes MK6 2TA a 3 Warren Yard Warren Park Stratford Road Milton Keynes Buckinghamshire MK12 5NW in data 10 nov 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di Steven Bygrave come amministratore in data 22 mar 2013

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2014

    Stato del capitale al 01 lug 2014

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Nomina di Matthew James Evans come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Chancery Pavilion Boycott Avenue Oldbrook Milton Keynes MK6 2TA* in data 01 lug 2014

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Bedford Heights Manton Lane Bedford MK41 7PH United Kingdom* in data 20 giu 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di Mr Matthew James Evans come amministratore

    3 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Miranda Van Den Ouden come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Francis come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Miranda Van Den Ouden il 15 mar 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    7 pagineMG01

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Miranda Van Den Ouden il 01 nov 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Paul Langford come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 27 Saint Cuthberts Street Bedford Bedfordshire MK40 3JG* in data 01 apr 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di VAN DEN OUDEN LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BYGRAVE, Stephen Michael
    Meadfoot Place
    MK41 7GH Bedford
    22
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Meadfoot Place
    MK41 7GH Bedford
    22
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish18705120003
    EVANS, Matthew James
    Grange Road
    Blunham
    MK44 3NT Bedford
    117
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Grange Road
    Blunham
    MK44 3NT Bedford
    117
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish142154180002
    BYGRAVE, Linda Irene
    88 Kimbolton Road
    MK40 2PE Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    88 Kimbolton Road
    MK40 2PE Bedford
    Bedfordshire
    British76939580001
    FRANCIS, Jane Louise
    Balmoral Avenue
    NN10 0BE Rushden
    19
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Segretario
    Balmoral Avenue
    NN10 0BE Rushden
    19
    Northamptonshire
    United Kingdom
    159029240001
    SHARMAN, Leslie Robert
    265 Bedford Road
    Kempston
    MK42 8BP Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    265 Bedford Road
    Kempston
    MK42 8BP Bedford
    Bedfordshire
    British68818590001
    CROUCHER NEEDHAM LIMITED
    St Cuthberts Street
    MK40 3JG Bedford
    27
    Bedfordshire
    Segretario
    St Cuthberts Street
    MK40 3JG Bedford
    27
    Bedfordshire
    136069720001
    OFFICE COMPLIANCE SOLUTIONS LIMITED
    St Cuthberts Street
    MK40 3JG Bedford
    27
    Bedfordshire
    Segretario
    St Cuthberts Street
    MK40 3JG Bedford
    27
    Bedfordshire
    129370230001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BYGRAVE, Linda Irene
    88 Kimbolton Road
    MK40 2PE Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    88 Kimbolton Road
    MK40 2PE Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish76939580001
    LANGFORD, Paul John
    Hookhams Lane
    Renhold
    MK41 0JX Bedford
    74
    Bedfordshire
    Amministratore
    Hookhams Lane
    Renhold
    MK41 0JX Bedford
    74
    Bedfordshire
    EnglandBritish137927160001
    VAN DEN OUDEN, Miranda
    Oakley Road
    Bromham
    MK43 8HY Bedford
    12
    England
    Amministratore
    Oakley Road
    Bromham
    MK43 8HY Bedford
    12
    England
    United KingdomDutch68818580005

    VAN DEN OUDEN LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 17 feb 2012
    Consegnato il 22 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 3A linnetts lane higham ferrers rushden northamptonshire t/no NN306284.
    Persone aventi diritto
    • Harpmanor Limited
    Transazioni
    • 22 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2012
    Consegnato il 22 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 3A linnetts lane higham ferrers rushden northamptonshire t/no NN306284 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Harpmanor Limited
    Transazioni
    • 22 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 05 mag 2005
    Consegnato il 14 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 39 & 39 northampton road, broham, bedford, bedfordshire t/no BD112479 and BD227790 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 14 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 mag 2005
    Consegnato il 14 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 39 & 39 northampton road, broham, bedford, bedfordshire t/no BD112479 and BD227790. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 14 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 11 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining 11 grays grove little staughton bedfordshire MK44 2BT. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0