CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03948247
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Quantum House
    Challenge Way
    WF17 6JN Batley
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMCO (142000) LIMITED15 mar 200015 mar 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 giu 2011

    Stato del capitale al 03 giu 2011

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 lug 2010

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da St Pegs House Thornhill Beck Lane Brighouse West Yorkshire HD6 4AH in data 31 ago 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Faron Mitchell Dukes come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2009

    8 pagineAA

    Nomina di Phillip James Astley come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2008

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    4 pagine395

    legacy

    6 pagine395

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2007

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2006

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DANIELSON, Margaret
    Gosport Close
    Outlane
    HD3 3FP Huddersfield
    24
    Kirklees
    Segretario
    Gosport Close
    Outlane
    HD3 3FP Huddersfield
    24
    Kirklees
    British135596620001
    ASTLEY, Philip James
    Challenge Way
    WF17 6JN Batley
    Quantum House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Challenge Way
    WF17 6JN Batley
    Quantum House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director111541840001
    BIGHAM, Lucas Richard
    Highbank
    Tintwistle
    SK13 1LP Glossop
    8
    Derbyshire
    Amministratore
    Highbank
    Tintwistle
    SK13 1LP Glossop
    8
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector135596730001
    BURNS, Philip
    23 Oakdale
    HG1 2LL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    23 Oakdale
    HG1 2LL Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector50889930003
    DUKES, Faron Mitchell
    Challenge Way
    WF17 6JN Batley
    Quantum House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Challenge Way
    WF17 6JN Batley
    Quantum House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManufacturing Director138692720001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Segretario
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    British72052540003
    FITZGERALD, Michael Kevin
    90 Westfield Road
    Carlton
    WF3 3RJ Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    90 Westfield Road
    Carlton
    WF3 3RJ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary/Director71385580002
    FITZGERALD, Michael Kevin
    12 Hopefield Walk
    Rothwell
    LS26 0YA Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    12 Hopefield Walk
    Rothwell
    LS26 0YA Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector71385580001
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Segretario
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British50767140001
    KHM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Old Cathedral Vicarage St James Row
    S1 1XA Sheffield
    Segretario
    Old Cathedral Vicarage St James Row
    S1 1XA Sheffield
    61699950001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    BritishSolicitor72052540003
    FITZGERALD, Michael Kevin
    90 Westfield Road
    Carlton
    WF3 3RJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    90 Westfield Road
    Carlton
    WF3 3RJ Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Secretary/Director71385580002

    CONTROLLED SPEED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 dic 2008
    Consegnato il 10 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yfm Venture Finance Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    St peggs house, thornhill, beck lane, brighouse t/no WYK744543 including all additions thereto and all fixtures and all fittings, all fixed plant and machinery, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2003
    Consegnato il 10 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a st. Pegs house thornhills beck lane brighouse t/no: WYK697622.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 02 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0