TNT PUBLISHING LIMITED

TNT PUBLISHING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTNT PUBLISHING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03948613
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TNT PUBLISHING LIMITED?

    • (2215) /

    Dove si trova TNT PUBLISHING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O
    MOORFIELDS CORPORATE RECOVERY LLP
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TNT PUBLISHING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRADER MEDIA (TNT) LIMITED22 lug 200222 lug 2002
    MANTISFLOW LIMITED10 apr 200010 apr 2000
    EASTHEMP LIMITED15 mar 200015 mar 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di TNT PUBLISHING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TNT PUBLISHING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagine4.72

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:court order replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    5 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2013

    21 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:court order - removal of liquidator
    7 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 mar 2012

    17 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 mar 2012

    14 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    22 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    7 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Greycoat Place London SW1P 1SB United Kingdom in data 12 set 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 lug 2011

    Stato del capitale al 05 lug 2011

    • Capitale: GBP 1,100,100
    SH01

    Nomina di Mr David Alstin come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 14-15 Childs Place Earls Court London SW5 9RX in data 16 feb 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Jeffrey Perkins come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Anthony Goodman come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TNT PUBLISHING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRAMPTON, Nick
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Segretario
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    148299020001
    ALSTIN, David
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Amministratore
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    United KingdomBritishCommercial Director159609080001
    CRAMPTON, Nick
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Amministratore
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    United KingdomBritishFinance Director148432740001
    ELLIS, Kevin James
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Amministratore
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    United KingdomBritishCeo (Interim)147377220001
    HURST, Kenneth
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Amministratore
    c/o C/O
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    United KingdomBritishChairman36255180001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Segretario
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    BritishAccountant15959630001
    GODDARD, Mark David
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    Segretario
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    BritishGroup Managing Director71765190002
    GODDARD, Mark David
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    Segretario
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    BritishDirector71765190002
    HERMER, Stephen Jeremy
    96 Kensington Church Street
    W8 4BU London
    Segretario
    96 Kensington Church Street
    W8 4BU London
    British64290150002
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Segretario
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    BritishDirector128648070001
    LACEY, Eugenia
    151 Ash Street
    GU12 6LJ Ash
    Surrey
    Segretario
    151 Ash Street
    GU12 6LJ Ash
    Surrey
    BritishGroup Treasurer79114130001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    BritishDirector162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Segretario
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanAccountant97879810002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    DUPREE, John
    Swilly Farm
    Crowpiece Lane
    ST3 9SG Farnham Royal
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Swilly Farm
    Crowpiece Lane
    ST3 9SG Farnham Royal
    Buckinghamshire
    BritishPublishing69463030002
    GLITHERO, Sean
    34 Langborough Road
    RG40 2BT Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    34 Langborough Road
    RG40 2BT Wokingham
    Berkshire
    BritishGroup Financial Controller118005980001
    GODDARD, Mark David
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    BritishGroup Managing Director71765190002
    GODDARD, Mark David
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    9 Pasture Close
    Lower Earley
    RG6 4UY Reading
    Berkshire
    BritishDirector71765190002
    GOODMAN, Anthony John
    71 Gunterstone Road
    W14 9BS London
    Flat 1
    Amministratore
    71 Gunterstone Road
    W14 9BS London
    Flat 1
    United KingdomAustralianMarketing Manager128648810001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    BritishAccountant86019470001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Executive46555440002
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Amministratore
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited KingdomCompany Director155633620001
    MURRAY-JONES, James Richard
    GU28 9EN Northchapel
    The Creek
    West Sussex
    Amministratore
    GU28 9EN Northchapel
    The Creek
    West Sussex
    BritishCheif Executive Officer130806290001
    PARKER, Philip John
    20 Pine Gardens
    Berrylands
    KT5 8LH Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    20 Pine Gardens
    Berrylands
    KT5 8LH Surbiton
    Surrey
    BritishConsultant27915930002
    PEAKE, Timothy
    31 Redshots Close
    SL7 3LW Marlow
    Bucks
    Amministratore
    31 Redshots Close
    SL7 3LW Marlow
    Bucks
    BritishManaging Director121766400002
    PERKINS, Jeffrey
    Childs Place
    Earls Court
    SW5 9RX London
    14-15
    Amministratore
    Childs Place
    Earls Court
    SW5 9RX London
    14-15
    United KingdomBritishHead Of Sales146205050001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanAccountant97879810002
    STOREY, Graham Neil
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector48939070004
    TOLLEY, Benjamin David
    11a Nugent Terrace
    NW8 9QB London
    Amministratore
    11a Nugent Terrace
    NW8 9QB London
    BritishSolicitor114344080001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TNT PUBLISHING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security confirmation deed
    Creato il 21 dic 2009
    Consegnato il 29 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    To the extent not already charged as security for the secured liabilities the chargor with full title gurantee respectively charged mortgaged and assigned in favour of the lender on the terms see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transazioni
    • 29 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 26 feb 2008
    Consegnato il 05 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V.
    Transazioni
    • 05 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P.Morgan Europe Limtied as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession
    Creato il 27 ott 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents the senior subordinated facility agreement and the hedging documents (all as defined)
    Brevi particolari
    Pursuant to the debenture the subsidiary as beneficial owner and with full title guarantee as security for the payment discharge and performance of all of the secured liabilties charges in favour of the security agent (as agent and trustee for itself and each of the lenders) by way of first fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Agas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TNT PUBLISHING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 set 2011Inizio dell'amministrazione
    28 mar 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    2
    DataTipo
    28 mar 2012Inizio della liquidazione
    15 apr 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0