MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED

MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03948742
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    14 Bonhill Street
    EC2A 4BX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 gen 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al06 mar 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma20 mar 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al06 mar 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2024

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor Allan House 10 John Prices Street London W1G 0AH a 14 Bonhill Street London EC2A 4BX in data 27 apr 2024

    3 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2023

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2022

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2021

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2020

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2019

    11 pagineLIQ03

    Soddisfazione dell'onere 039487420013 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Wellington House Cliffe Park Bruntcliffe Road Morley Leeds West Yorkshire LS27 0RY a 4th Floor Allan House 10 John Prices Street London W1G 0AH in data 19 ott 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 set 2018

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 039487420011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039487420012 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 039487420013, creata il 20 dic 2017

    105 pagineMR01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 ott 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Iscrizione dell'ipoteca 039487420012, creata il 27 set 2017

    100 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 039487420010 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Manish Mansukhlal Gudka come amministratore in data 27 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Edward Purtill come amministratore in data 27 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Gareth Jones come amministratore in data 27 set 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Amministratore
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    United KingdomBritishCompany Director163227370001
    JONES, Gareth
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Amministratore
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    EnglandBritishChartered Accountant121225470001
    GOULDING, Ian Don
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    Segretario
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    BritishDirector39828490004
    KINGSTON, Mark Andrew
    Whitehall Farm
    Brissenden Green
    TN26 3BJ Bethersden
    Kent
    Segretario
    Whitehall Farm
    Brissenden Green
    TN26 3BJ Bethersden
    Kent
    British47452060001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    GOULDING, Ian Don
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    Amministratore
    Scotgate Road
    Honley
    HD9 6RE Holmfirth
    4 St David's Court
    England
    EnglandBritishDirector39828490044
    MARSTON, Andrew John
    9 Clifton Crescent
    TR11 3QQ Falmouth
    Cornwall
    Amministratore
    9 Clifton Crescent
    TR11 3QQ Falmouth
    Cornwall
    United KingdomBritishCraftsman80440350001
    MARSTON, Anne Elizabeth
    The Water Mill Mill Road
    CT21 5LP Hythe
    Kent
    Amministratore
    The Water Mill Mill Road
    CT21 5LP Hythe
    Kent
    EnglandBritishBusiness Woman/Designer26207060001
    MARSTON, Caroline Louise
    17 Kempson Road
    Fulham
    SW6 4PX London
    Amministratore
    17 Kempson Road
    Fulham
    SW6 4PX London
    United KingdomBritishInterior Designer Property Man23234380003
    MARSTON, Caroline Louise
    43 Campana Road
    Fulham
    SW6 4AT London
    Amministratore
    43 Campana Road
    Fulham
    SW6 4AT London
    BritishInterior Designer/Property Man23234380002
    MARSTON, John James Shepherd
    Flat 2 41 Carlton Drive
    Putney
    SW15 2DG London
    Amministratore
    Flat 2 41 Carlton Drive
    Putney
    SW15 2DG London
    BritishCivil Engineer/Director23402360001
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Amministratore
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrishDirector7856280001
    SCRAGG, Christopher David
    Boughton Malherbe
    Old Rectory
    ME17 2BD Sandway
    Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Boughton Malherbe
    Old Rectory
    ME17 2BD Sandway
    Maidstone
    Kent
    BritishHotelier27676690001
    TAYLOR, David James
    18 Spencers Way
    HG1 3DN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    18 Spencers Way
    HG1 3DN Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector88020060001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Wellington House
    England
    06 mar 2017
    Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Wellington House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5961557
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Devonshire Point Investment S.A.R.L
    Rue Lou Hemmer
    L-1748 Findel
    4
    Luxembourg
    06 mar 2017
    Rue Lou Hemmer
    L-1748 Findel
    4
    Luxembourg
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneLuxembourg
    Autorità legaleLuxembourg
    Luogo di registrazioneRegistre De Commerce Et Des Societes
    Numero di registrazioneB185413
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 dic 2017
    Consegnato il 21 dic 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 21 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2017
    Consegnato il 05 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 05 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2017
    Consegnato il 03 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 03 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 apr 2016
    Consegnato il 20 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 20 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 ott 2014
    Consegnato il 13 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Hotels Holdings Limited
    Transazioni
    • 13 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A third composite guarantee and debenture
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 01 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a the queens hotel city square leeds t/no wyk 316711, f/h property k/a le meridien warwick kenilworth road warwick t/no wk 283205, f/h property k/a east and west spinneys wooton hill wooton t/no wk 380830 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alchemy Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 31 march 2003
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 01 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a aldwark manor hotel aldwark with f/h t/nos NYK122375, NYK90041, NYK71225, NYK83484, NYK92442, NYK148380, NYK234396 and NYK240246 and l/h t/nos NYK318092 and NYK323067, f/h and l/h property k/a the bridgewood manor hotel chatham kent with f/h t/nos K653107, K700887, K804549, K648515, K820379 and K709527 and l/h t/no K897127 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transazioni
    • 01 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 24 february 2004
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 01 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a aldwark manor hotel aldwark with f/h t/nos NYK122375, NYK90041, NYK71225, NYK83484, NYK92442, NYK148380, NYK234396 and NYK240246 and l/h t/nos NYK318092 and NYK323067, f/h and l/h property k/a the bridgewood manor hotel chatham kent with f/h t/nos K653107, K700887, K804549, K648515, K820379 and K709527 and l/h t/no K897127 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transazioni
    • 01 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share charge
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 27 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee (and/or the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge, the investments including all rights of enforcement of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 27 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee (and/or the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 16 nov 2005
    Consegnato il 24 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of a chargor to any finance party,the hedging bank and the overdraft bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H aldwark manor hotel t/no's NYK122375,NYK90041,NYK148380,NYK71225,NYK83484,NYK02442,NYK234396,NYK240246, f/h bridgewood manor hotel K653107,K700887,K804549,K648515, l/h cambridge belfry hotel CB288015,CB288016 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 24 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2003
    Consegnato il 14 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MARSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 set 2018Inizio della liquidazione
    27 set 2018Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Harry Hyams
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London
    Praticante
    4th Floor Allan House
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0