QUINTAIN (NO.12) LIMITED

QUINTAIN (NO.12) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQUINTAIN (NO.12) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03954402
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QUINTAIN (NO.12) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova QUINTAIN (NO.12) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di QUINTAIN (NO.12) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per QUINTAIN (NO.12) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Alexander Edward Compton Hare il 12 lug 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 17 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Andrew Tatford come amministratore in data 17 mar 2017

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Nomina di Alexander Edward Compton Hare come amministratore in data 05 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come amministratore in data 05 ott 2016

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 17 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2016

    Stato del capitale al 21 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Sandra Judith Odell come amministratore in data 31 mar 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 31 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Maxwell David Shaw James come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard James Stearn come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2015

    Stato del capitale al 02 apr 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Stearn il 10 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 04 ago 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sandra Judith Odell il 04 ago 2014

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 16 Grosvenor Street London W1K 4QF a 43-45 Portman Square London W1H 6LY in data 05 ago 2014

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di QUINTAIN (NO.12) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARE, Alexander Edward Compton, Mr
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish215786330002
    TATFORD, Simon Andrew
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XS London
    Flat 53 Globe Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XS London
    Flat 53 Globe Wharf
    United Kingdom
    United KingdomBritish228195340001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175340980001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    DUGDALE, Edward Stratford
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    Amministratore
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    British35942980001
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish164108510001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish132142980001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish42858810002
    MIKJON LIMITED
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    Amministratore
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    72341560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QUINTAIN (NO.12) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2694983
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    QUINTAIN (NO.12) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 04 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 ott 2007
    Consegnato il 25 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 15 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Facility Agent)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation amending a floating charge dated 22 may 2001
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 15 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Particulars of all the property mortgaged or charged are as contained in the original floating charge registered at companies house on 02 june 2001.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 22 mag 2001
    Consegnato il 02 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from quintain estates and development PLC to the chargee under the financing documents (as the same may be amended and/or supplemented) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets and undertakings.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0