UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03958461 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
- Trasporto via condotte (49500) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Synergy House Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHOIRCLOSE LIMITED | 28 mar 2000 | 28 mar 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Energy House Woolpit Business Park Woolpit Bury St Edmunds Suffolk IP30 9UP a Synergy House Windmill Avenue Woolpit Bury St. Edmunds IP30 9UP in data 19 giu 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Buuk Infrastructure No 2 Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di The Gas Transportation Company Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon John Lee come segretario in data 17 giu 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Neil Shaw come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Clive Eric Linsdell il 23 ott 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Darryl John Corney come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUMFORD, Christopher | Segretario | Ellen Street CF10 4BP Cardiff Driscoll 2 | British | 177345530001 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Amministratore | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British | 83564940010 | |||||
| LINSDELL, Clive Eric | Amministratore | Energy House Woolpit Business Park IP30 9UP Woolpit Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 175552240002 | |||||
| LARGENT, Barry Roy | Segretario | Lavender Cottage The Street Rickinghall IP22 1EG Diss Norfolk | British | 108745880001 | ||||||
| LEE, Simon John | Segretario | Langham Place Highwoods CO4 9GB Colchester 7 Essex United Kingdom | British | 137019500001 | ||||||
| O'RIORDAN, William Gerard | Segretario | Shalom Curraclough Lissarda Cork Ireland | British | 70535680001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| CARR, Michael Derek | Amministratore | Redstones Beacon Road TN6 3SX Crowborough Sussex | British | 28872750001 | ||||||
| CHARLTON, Philip | Amministratore | 62 Quinta Drive Arkley EN5 3BE Barnet Hertfordshire | British | 145449850001 | ||||||
| FITZGERALD, Eugene Bernard | Amministratore | Cloduv 2 Melbourn Road Bishopstown Cork Ireland | Irish | 92991480001 | ||||||
| GEOGHEGAN, Gerard | Amministratore | 2 Claremont Pines IRISH Carrickmines Dublin 18 Ireland | Irish | 70535790001 | ||||||
| JEMMETT, Richard William | Amministratore | 110 Northcott RG12 7WS Bracknell Berkshire | England | British | 68677410002 | |||||
| KENNA, Anthony Kevin | Amministratore | 18 Pine Valley Drive Grange Road Dublin 16 Ireland | Irish | 70535940001 | ||||||
| LAYTON, Matthew Robert | Amministratore delegato nominato | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MORGAN, Dawn Caroline | Amministratore | Energy House Woolpit Business Park IP30 9UP Woolpit Bury St Edmunds Suffolk | Uk | British | 105434660003 | |||||
| NICHOLSON, Thomas Edward | Amministratore | 19 The Elms Stillorgan Road Donnybrook Dublin 4 Ireland | Irish | 70535860001 | ||||||
| PURCELL, David Colm | Amministratore | 231 Crodaun Forrest Park IRISH Celbridge County Kildare Ireland | Irish | 70535720002 | ||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| RICHARDS, Michael Roy | Amministratore | Spruce Cottage Newbridge, Cadnam SO40 2NW Southampton Hampshire | England | British | 18060690002 | |||||
| SHAW, Neil Edward | Amministratore | Woolpit Business Park Woolpit IP31 9UP Bury St. Edmunds Energy House Suffolk | United Kingdom | British | 107757420001 | |||||
| SPRUCE, Anthony | Amministratore | Sans Pareil Rue Savage CHANNEL St Sampsons Guernsey | British | 26954450001 | ||||||
| WALSH, Robert Gerard | Amministratore | Windsor Ovens, Co Cork Ireland | Irish | 104100510001 | ||||||
| WILSON, Francis Donald | Amministratore | Middle Lodge Woodfold Park Preston New Road Mellor BB2 7NP Blackburn Lancs | England | British | 10721020001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gas Transportation Company Limited | 06 apr 2016 | Admiral Park GY1 3HB St Peter Port Martello Court Guernsey Channel Islands | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Buuk Infrastructure No 2 Limited | 06 apr 2016 | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Energy House Suffolk England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Creato il 30 gen 2007 Consegnato il 06 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its right title and interest present and future in, under and to the contract meaning the intercompany loan agreement dated 28 april 2006. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0