JAYLIMA PROPERTIES LIMITED

JAYLIMA PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJAYLIMA PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03965389
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JAYLIMA PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova JAYLIMA PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Copper House
    Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford Green
    Essex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di JAYLIMA PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per JAYLIMA PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Trevor Keeble il 11 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 apr 2012

    Stato del capitale al 05 apr 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr James Trevor Keeble come amministratore in data 07 feb 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Enamur Rahman come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Haslers Old Station Road Loughton Essex IG10 4PL in data 16 ago 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Enamur Rahman come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di James Daniels come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2007

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di JAYLIMA PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RAHMAN, Enamur
    Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford Green
    Copper House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford Green
    Copper House
    Essex
    United Kingdom
    152777220001
    KEEBLE, James Trevor
    88 Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford
    Copper House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    88 Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford
    Copper House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Adviser127852330002
    RAHMAN, Enamur
    Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford Green
    Copper House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    Snakes Lane East
    IG8 7HX Woodford Green
    Copper House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant158634550001
    SMITH, Henry Thomas
    Great Oaks
    Bury Road Sewardstonebury
    E4 7QL London
    Amministratore
    Great Oaks
    Bury Road Sewardstonebury
    E4 7QL London
    United KingdomBritishInvestor142764470001
    BURTON, Colin
    14 Barnsley Road
    RM3 9LP Romford
    Essex
    Segretario
    14 Barnsley Road
    RM3 9LP Romford
    Essex
    British86084200001
    DANIELS, James
    21 Byron Avenue
    South Woodford
    E18 2HH London
    Segretario
    21 Byron Avenue
    South Woodford
    E18 2HH London
    BritishAccountant110484910001
    STEDMAN, Simon Christoffer
    45 Ford End
    IG8 0EG Woodford Green
    Essex
    Segretario
    45 Ford End
    IG8 0EG Woodford Green
    Essex
    British65797310001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    NEWMAN, Philip
    21 Station Road
    CM16 4HG Epping
    Essex
    Amministratore
    21 Station Road
    CM16 4HG Epping
    Essex
    BritishDirector70876800001
    ROSE, Paul Clifford
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    Amministratore
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    United KingdomBritishManager52815670001
    SMITH, Henry Thomas
    Great Oaks
    Bury Road Sewardstonebury
    E4 7QL London
    Amministratore
    Great Oaks
    Bury Road Sewardstonebury
    E4 7QL London
    United KingdomBritishDirector142764470001
    STEDMAN, Simon Christoffer
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritishAccountant190800880001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    JAYLIMA PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of debenture
    Creato il 14 mag 2004
    Consegnato il 02 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each trustee and each borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge
    Creato il 14 mag 2004
    Consegnato il 02 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the f/h land k/a 46 fairfield road bow london E3 title absolute t/n EGL369585. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 07 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 29 broomfield street london E14. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ott 2001
    Consegnato il 02 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0