HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED

HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03967855
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HF RETAIL LIMITED18 mag 200018 mag 2000
    GOLDMIRROR LIMITED07 apr 200007 apr 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    3 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 07 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 apr 2012

    Stato del capitale al 11 apr 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher James Giles come amministratore in data 05 set 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore in data 05 set 2011

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 07 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di David Charles Geoffrey Foster come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di David Charles Geoffrey Foster come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Muller come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Patricia Kennerley come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Aylward come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Muller come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Christopher James Giles come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    15 pagineAA

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Segretario
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150401650001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Amministratore
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritish59741430002
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    HEALEY, Paul
    17 The Riverside
    NE31 1BG Hebburn
    Tyne & Wear
    Amministratore
    17 The Riverside
    NE31 1BG Hebburn
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish103942480002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Amministratore
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MCCLINTOCK, Jonathan Philip
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British104364530001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002
    PILSBURY, Roger Graham
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    Amministratore
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    United KingdomBritish181627090001
    SNEDDON, Graham
    4 Lowes Court The Downs
    Nevilles Cross
    DH1 4NR Durham
    Amministratore
    4 Lowes Court The Downs
    Nevilles Cross
    DH1 4NR Durham
    UkBritish79275980001
    TWEEDIE, Allen Mccaskill, Dr
    145 Western Way
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9LY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    145 Western Way
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9LY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British104507790001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the post office buildings, front street, south hetton, county durham.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 alexandra terrace stocksfield northumberland t/no ND103722, f/h 127 prince consort road gateshead tyne & wear t/no TY270189 and f/h 73 waterloo road blyth northumberland t/NOND142431 for details of further properties charged please refer to form 395 floating charge over all undertakings property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 14 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited and Barclay Pharmaceutical Limited
    Transazioni
    • 14 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 14 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 14 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 07 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0