NORTH HILL HOUSE LTD
Panoramica
| Nome della società | NORTH HILL HOUSE LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03968590 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NORTH HILL HOUSE LTD?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NORTH HILL HOUSE LTD?
| Indirizzo della sede legale | Fifth Floor 80 Hammersmith Road W14 8UD London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH HILL HOUSE LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per NORTH HILL HOUSE LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Moran come amministratore in data 01 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Mark Moran come amministratore in data 01 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason David Lock come amministratore in data 01 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 21 Exhibition House Addison Bridge Place London W14 8XP England* in data 23 lug 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Priory House Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TP* in data 04 ago 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jason David Lock il 28 apr 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David James Hall il 28 apr 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NORTH HILL HOUSE LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, David James | Segretario | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | British | 132246660001 | ||||||
| HALL, David James | Amministratore | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | 132246660001 | |||||
| BRADSHAW, Sarah Jane | Segretario | Swallow Barn The Cross BA11 2QS Buckland Dinham Somerset | British | 48580620001 | ||||||
| GREENSMITH, Paul John | Segretario | 8 Ennerdale Road Kew TW9 3PG Richmond Upon Thames Surrey | British | 150227000001 | ||||||
| MUKERJI, Swagatam | Segretario | The Peacocks Drews Park, Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | British | 121222440001 | ||||||
| SPRUZEN, David Andrew | Segretario | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | British | 110080200001 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Segretario nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
| BRADSHAW, Stephen Wallace | Amministratore | Great Elm BA11 3NY Nr Frome Glenthorpe Somerset | England | British | 132026810001 | |||||
| BRADSHAW, Stephen Wallace | Amministratore | Swallow Barn Buckland Dinham BA11 2QS Frome Somerset | British | 70594890001 | ||||||
| GREENSMITH, Paul John | Amministratore | 8 Ennerdale Road Kew TW9 3PG Richmond Upon Thames Surrey | England | British | 150227000001 | |||||
| LEE, Terry | Amministratore | 19 Darcy Road Tiptree CO5 0RR Colchester Essex | British | 85337930001 | ||||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | 144822040001 | |||||
| MACK, Torsten | Amministratore | 61 Swish Building 73 Upper Richmond Road SW15 2SR London | German | 93474760003 | ||||||
| MORAN, Mark | Amministratore | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor | United Kingdom | British | 60066000008 | |||||
| MUKERJI, Swagatam | Amministratore | The Peacocks Drews Park, Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 121222440001 | |||||
| PATEL, Chaitanya Bhupendra | Amministratore | Robin Hill Warren Lane KT22 0ST Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 63915280004 | |||||
| SPRUZEN, David Andrew | Amministratore | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | England | British | 110080200001 | |||||
| STEWART, Serena Jane | Amministratore | 23 Lindsey Street CM16 6RB Epping Essex | British | 57758710001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher, Professor | Amministratore | 3 Preshaw House Preshaw SO32 1HP Upham Hampshire | United Kingdom | British | 162000490001 | |||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Amministratore delegato nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NORTH HILL HOUSE LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priory Old Schools Services Ltd | 06 apr 2016 | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NORTH HILL HOUSE LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 05 giu 2009 Consegnato il 12 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its rights in respect of any relevant contract - blenheim healthcare limited, loan agreement dated 15 june 2009. priory healthcare investments limited loan agreement dated 15 june 2009. priory group limited loan agreement dated 15 june 2009. for details of further relevant contracts charged please refer to form 395, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 09 nov 2005 Consegnato il 22 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 15 set 2005 Consegnato il 26 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H property k/a priory hospital altrincham rappax road altrincham cheshire t/no GM32147, priory hospital bristol heath house lane off bell hill bristol t/no AV204454, f/h property k/a priory grange heath house lane purdown bristol t/no AV247767. For details of further properties charge please refer to form 395. all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery and floating charge all assets no effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental debenture | Creato il 02 set 2005 Consegnato il 08 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The aggregate of all obligations moneys and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The supplemental debenture property agreements contracts deeds licences rental income insurance policies all present and future assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Amendment and restatement deed | Creato il 19 set 2003 Consegnato il 09 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the other obligors or the issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All shares held in the future and in relation to such shares; all dividends, interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Borrower debenture | Creato il 04 set 2003 Consegnato il 23 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The aggregate of all obligations moneys and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all right title and interest in and to the english real property, the tangible moveable property, the obligor accounts; the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 12 ott 2001 Consegnato il 22 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or farleigh schools limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0