RED FUNNEL GROUP LIMITED

RED FUNNEL GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRED FUNNEL GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03968658
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LINKSGOOD LIMITED10 apr 200010 apr 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 039686580020 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039686580021 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione di Red Funnel Group (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    1 paginePSC07

    Notifica di Falcon Acquisitions Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    2 paginePSC02

    Soddisfazione dell'onere 039686580022 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 gen 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share prem and cap redemption reserve cancelled 31/01/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Charles John Gore Hazelwood come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Arthur Wilson come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Francis Campbell come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    22 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 039686580019 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039686580018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 039686580017 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 039686580022, creata il 20 lug 2017

    17 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 039686580021, creata il 20 lug 2017

    9 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 039686580020, creata il 20 lug 2017

    40 pagineMR01

    Cessazione della carica di Maria Georgina Dellacha come amministratore in data 07 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Keith James Nelson come amministratore in data 07 lug 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GEORGE, Kevin Alan
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishChief Executive186130710001
    WINTER, Paul Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishAccountant132752850001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Segretario
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    BritishFinance Director8125620001
    SHEARD, John Paul
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    Segretario
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    British61554710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLAND, Christopher Donald Jack
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    United KingdomBritishCompany Director8125610001
    BRADBURY, Kenton Edward
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishDirector147513860001
    CAMPBELL, Michael Francis
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    CanadaCanadianCompany Director235365510001
    COOPER, James Nigel Shelley
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishCompany Director265561970001
    DELLACHA, Maria Georgina
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishAsset Management Company Director174489750001
    DOCHERTY, Thomas James
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishManaging Director83269560002
    DUPONT, Pierre Arthur Raoul
    Flat2
    170 Holland Park
    W11 4UH London
    Amministratore
    Flat2
    170 Holland Park
    W11 4UH London
    BelgianInvestment Officer70838360002
    HAZELWOOD, Charles John Gore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishCompany Director111535480002
    HELMORE, Max David Charles
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishCompany Director174349030001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    BritishFinance Director8125620001
    NELSON, Stephen Keith James
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishBusiness Executive179946540001
    PATON, Hugh
    30 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NP London
    Amministratore
    30 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NP London
    BritishBanker73255110001
    SCHUMACHER, Bernd
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandGermanCompany Director169583030001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritishFinance Director107002130001
    STOKHUYZEN, Wiet Austin
    73 Rostrevor Road
    SW6 5AR London
    Amministratore
    73 Rostrevor Road
    SW6 5AR London
    BritishInvestment Officer73695170002
    WHYTE, Alistair Morrison
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector8125600001
    WILSON, Edward Arthur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Falcon Acquisitions Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 gen 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione06238324
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Red Funnel Group (Holdings) Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    06 apr 2016
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneUk Company Register
    Numero di registrazione05115188
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RED FUNNEL GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 lug 2017
    Consegnato il 31 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All current and future land (except for restricted land) (including, amongst other land, the property at 7 the arcade, cowes, PO31 7AR with title number IW51117) together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01 (the "instrument"). For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 31 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 lug 2017
    Consegnato il 27 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A ship known as "red jet 4" (official number 906937).
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited
    Transazioni
    • 27 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 lug 2017
    Consegnato il 27 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A ship called red jet 4 with official number 906937.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 27 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 13 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A ship k/a "red jet 4". official number 906937.
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 13 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 12 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold property at 7 the arcade cowes title number IW51117. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 12 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 12 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Red jet 4 official number 906937.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 12 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental assignment of insurance
    Creato il 01 mag 2009
    Consegnato il 07 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rights title and interest in and to the red jet 5 marine insurances and all its benefits and interests present and future therein. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A statutory ship mortgage
    Creato il 25 ott 2007
    Consegnato il 02 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sixty four shares in the vessel red jet 4 official number 906937.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenants
    Creato il 25 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest, present and future in the ship being the vessel red jet 4 (official number 906937); and the earnings and the requisition compensation and all its benefits and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of insurance
    Creato il 25 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the chargor's rights, title and interest in and to the marine insurances and all its benefits and interests present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    7 the arcade, cowes t/no. IW51117 and 8. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of a ship
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 26 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sixty four shares in the vessel.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trusee) for Andon Behalf of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 26 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenants
    Creato il 10 mag 2006
    Consegnato il 26 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the lessee to the lenders and each indemnitee or in each case any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its interests present and future in and to the vessel meaning, the whole of the motor vessel 'red jet 4' registered in the name of the owner at the port of southampton under official number 906937. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Lender and Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 10 mag 2006
    Consegnato il 20 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 20 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 fountain quay (west) cowes isle of wight t/n IW51117, 8 the arcade fountain quay (west) cowes isle of wight t/n IW51116, option to purchase land at whippingha. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment (relating to the passenger/car ferry bergen castle)
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the owner's right title and interest present and future in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenants (in respect of the ship bergen castle)
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its interest in and to the ship and all its right title and interest in and to the earnings the insurances charter guarantee and requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of a ship
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,007,000 and all other monies due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the ship described as bergen castle official number 907948 and in its appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant to accompany a mortgage of a ship
    Creato il 11 nov 2003
    Consegnato il 18 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,554,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed security the vessel named "red jet 4" official no 906937 including its hull, engines, instruments all other accessories and component parts thereof; all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation belonging to the vessel; a demise charter made 11TH november 2003; all other earnings, charters, charter guarantees, insurances and requisition compensation in respect of the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage of a ship
    Creato il 11 nov 2003
    Consegnato il 18 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    British vessel known as "red jet 4" official no 906937.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rfg deed of charge
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    An assignment by way of first fixed security of all right title and interest and other benefit (present and future) in, to and under the abph deed of tax covenant to the extent that such right title interest and other benefit relates to liabilities of siow or vectis including without limitation all rights to receive payments of any amounts which may become payable to it thereunder and all payments received by it thereunder all rights to serve notices and/or make demands thereunder and/or to take such steps as are required to cause payments to become due and payable thereunder and all rights ofaction in respect of any breach thereof and all rights to receive damages or obtain relief in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York (For Itself and on Behalf of the Other Red Funnel Secured Parties and Siow)
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2000
    Consegnato il 08 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined) and obligations due from the company to the security trustee or any of the other beneficiaries (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed charge over all tangible moveable property,the charged accounts,the intellectual property,goodwill and rights in relation to uncalled capital,the investments,all dividends,interest and other monies payable in respect of shares and other related rights and all monetary claims; the proceeds of any insurance policy and all related rights and all rights and claims in relation to any assigned account; all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants, warranties and other documents floating charge over all undertaking and assets,present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York as Security Trustee for the Benificiaries
    Transazioni
    • 08 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0