VARICK AND SPRING (UK) LIMITED

VARICK AND SPRING (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVARICK AND SPRING (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03971244
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    77 Oxford Street
    W1D 2ES London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MIVA (UK) LIMITED13 giu 200513 giu 2005
    ESPOTTING MEDIA (UK) LIMITED15 nov 200115 nov 2001
    E-SPOTTING (UK) LIMITED12 apr 200012 apr 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2016

    Stato del capitale al 03 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 12 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2016

    Stato del capitale al 12 gen 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2014

    Stato del capitale al 22 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Corrao come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Corrao come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    16 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 12 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da , Lasenby House 32 Kingly Street, London, W1B 5QQ, United Kingdom in data 27 mar 2012

    1 pagineAD01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 12 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PISARIS, John Boyd
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    Segretario
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    American120337940002
    PISARIS, John Boyd
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    Amministratore
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    UsaAmerican120337940002
    GEBBIE, David Alexander George
    11 Sherbrook Hill
    EX9 6DA Budleigh Salterton
    Devon
    Segretario
    11 Sherbrook Hill
    EX9 6DA Budleigh Salterton
    Devon
    British72590190003
    GOLDBERG, Stephen Jonathan
    235 St John Street
    EC1V 4NG London
    Segretario
    235 St John Street
    EC1V 4NG London
    British2227260004
    GOLDBERG, Stephen Jonathan
    103 Bridge Lane
    NW11 0EU London
    Greater London
    Segretario
    103 Bridge Lane
    NW11 0EU London
    Greater London
    British2227260001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Segretario nominato
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    ALLNER, Christopher Charles
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish78206300001
    BANCROFT COOKE, Nicholas Desmond James
    16 Ennismore Mews
    SW7 1AN London
    Amministratore
    16 Ennismore Mews
    SW7 1AN London
    EnglandBritish70337890001
    BISHOP, Sebastian Luke
    Lennox Gardens
    Lower Ground Flat
    SW3 0DG London
    44
    Amministratore
    Lennox Gardens
    Lower Ground Flat
    SW3 0DG London
    44
    British107286980002
    BISHOP, Sebastian Luke
    16 Randolph Road
    W9 1AN London
    Amministratore
    16 Randolph Road
    W9 1AN London
    British70337920002
    BOCAN, Jeff
    28 Bramham Gardens
    Flat 16
    SW5 0HE London
    Amministratore
    28 Bramham Gardens
    Flat 16
    SW5 0HE London
    British92312190002
    BUNIS, Jonathan
    Flat 10
    57 Holland Park
    W11 3RS London
    Amministratore
    Flat 10
    57 Holland Park
    W11 3RS London
    American124727110001
    BURGE, Alan
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    Amministratore
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish197259620001
    CORRAO, Peter
    Simsbury Rd
    06002 Bloomfield
    500
    Ct
    U S A
    Amministratore
    Simsbury Rd
    06002 Bloomfield
    500
    Ct
    U S A
    UsaU S A115277820002
    ISHAG, Daniel
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    Amministratore
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    Italian70927420002
    ISHAG, David
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    Amministratore
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    British79432110002
    LINDE, Carl
    13 Highfield Gardens
    NW11 9HD London
    Amministratore
    13 Highfield Gardens
    NW11 9HD London
    United KingdomSouth African70746870002
    MCDONNELL, Stephen
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Amministratore
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Irish107320020001
    MCDONNELL, Stephen
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Amministratore
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Irish107320020001
    PISARIS HENDERSON, Craig Allen
    11710 Rosemount Drive
    Fort Myers
    Florida 33913
    Usa
    Amministratore
    11710 Rosemount Drive
    Fort Myers
    Florida 33913
    Usa
    Us Citizen99452240002
    POULTER, Adam
    Waytefield
    9 Long Wood Drive
    HP9 2SS Jordans
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Waytefield
    9 Long Wood Drive
    HP9 2SS Jordans
    Buckinghamshire
    British114157480001
    ROBINSON, Lowell
    470 West End Avenue
    Apartment 2e
    10024 New York
    New York 10024
    Usa
    Amministratore
    470 West End Avenue
    Apartment 2e
    10024 New York
    New York 10024
    Usa
    American73871170001
    SEIPPEL, William
    190 Inwood Terrace
    Roswell Ga
    Fulton 30075
    U S A
    Amministratore
    190 Inwood Terrace
    Roswell Ga
    Fulton 30075
    U S A
    U S A American115277080001
    TAYLOR, Michael Todd
    Circa Apartments
    202 Regents Park Road
    NW1 8AD London
    Amministratore
    Circa Apartments
    202 Regents Park Road
    NW1 8AD London
    American120383420001
    THUNE, Phillip Ross
    7885 Go Canes Way
    Fort Myers
    Florida 33912
    Usa
    Amministratore
    7885 Go Canes Way
    Fort Myers
    Florida 33912
    Usa
    Us Citizen99452160001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Amministratore delegato nominato
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    VARICK AND SPRING (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 nov 2008
    Consegnato il 13 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bridge Bank N.A.
    Transazioni
    • 13 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 20709862 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or the parent to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Findwhat.Com
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 set 2003
    Consegnato il 23 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter V Miller Acting for Himself and as Trustee on Behalf of the Noteholders Under Theconvertible Loan Note Instrument (Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation and amendment to debenture
    Creato il 08 nov 2002
    Consegnato il 16 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For variation to charge see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Proven Private Equity Limited
    Transazioni
    • 16 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation and amendment to b notes debenture
    Creato il 08 nov 2002
    Consegnato il 16 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For variations to charge see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Proven Private Equity Limited
    Transazioni
    • 16 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets of the company as defined in the charge other than monies from time to time held subject to the terms of the escrow agreement.
    Persone aventi diritto
    • Dynamic Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 05 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Proven Private Equity Limited (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Noteholders,the Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation and amendment to the debenture dated 6 december 2001
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 05 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the proprety assets and undertaking of the chargor including book debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Proven Private Equity Limited (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Noteholders,the Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Escrow agreement
    Creato il 01 ago 2002
    Consegnato il 08 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subject to the provisions of clause 5 of the agreement, all its rights in the escrow account to yahoo!. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yahoo! UK Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 dic 2001
    Consegnato il 08 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or as evidenced by the loan notes (as defined in the debenture) and/or the loan note instrument (as defined in the debenture) and/or the subscription agreement (as defined in the debenture) and/or this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Proven Private Equity Limited,as Security Trustee and Its Successors
    Transazioni
    • 08 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0