HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED

HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARTSHEAD (GENERAL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03974935
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DUFF & PHELPS LTD.
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (2186) LIMITED17 apr 200017 apr 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    pagineAM22

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    33 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    36 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    44 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 apr 2017

    32 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    62 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    62 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da 74 Wimpole Street London W1G 9RR a C/O Duff & Phelps Ltd. the Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW in data 25 ott 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2016

    Stato del capitale al 04 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Graham Senior Swallow come segretario in data 15 gen 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew James Rudd come segretario in data 15 gen 2016

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2015

    Stato del capitale al 07 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    16 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 039749350011

    37 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 039749350010

    35 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RUDD, Andrew James
    Cedar Drive
    Barming
    ME16 9HD Maidstone
    8
    Kent
    England
    Segretario
    Cedar Drive
    Barming
    ME16 9HD Maidstone
    8
    Kent
    England
    205430690001
    BRADBROOK, Michael Leslie
    Tinkers Revel
    Herbage Park Road, Woodham Walter
    CM9 6RJ Maldon
    Essex
    Amministratore
    Tinkers Revel
    Herbage Park Road, Woodham Walter
    CM9 6RJ Maldon
    Essex
    EnglandBritishDirector3910960002
    SMITHIES, James Marchant
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishSurveyor37603190001
    GRANGEWOOD ENTERPRISES LIMITED
    Wimpole Street
    W1G 9RR London
    74
    England
    Amministratore
    Wimpole Street
    W1G 9RR London
    74
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03974935
    71345100002
    BRADBROOK, Michael Leslie
    18 Runsell Close
    Danbury
    CM3 4PQ Chelmsford
    Essex
    Segretario
    18 Runsell Close
    Danbury
    CM3 4PQ Chelmsford
    Essex
    BritishDirector3910960001
    SWALLOW, Graham Senior
    95 Glenwood Crescent
    Chapeltown
    S35 1YU Sheffield
    Segretario
    95 Glenwood Crescent
    Chapeltown
    S35 1YU Sheffield
    British58704150001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    GETTINGS, Edmund
    14 Base Green Avenue
    S12 3FA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    14 Base Green Avenue
    S12 3FA Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Secretary1790500001
    RYAN, Philip
    Fairway House
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fairway House
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector65488380001
    WARD, Bryan James
    High Ridge 115 Green Lane
    Dronfield
    S18 6FG Sheffield
    S Yorks
    Amministratore
    High Ridge 115 Green Lane
    Dronfield
    S18 6FG Sheffield
    S Yorks
    BritishDirector1790510001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 giu 2014
    Consegnato il 16 giu 2014
    In corso
    Breve descrizione
    A fixed charge over all the company’s right, title and interest in the balance for the time being on the rent account (whose details appear in part c of schedule 1 to the charging document) including all interest accrued thereon.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 giu 2014
    Consegnato il 12 giu 2014
    In corso
    Breve descrizione
    An assignment of all the right, title, benefit and interest (whether present or future) of the company in and to all rent, licence fees or other sums of money now or at any time received or recoverable by the company from any tenant or licensee of 1 hartshead square, sheffield, S1 2FD (title number SYK446227), and land comprising part of lower ground floor, part upper ground floor, part ground, first, second and third floors and the multi-storey car park areas of levels 1 to 7 (inclusive) forming part of churchill house, hartshead, sheffield S1 2EL (title number SYK462382), 1 hartshead square, sheffield, title number (SYK427511) and part of churchill house, hartshead, sheffield, S1 2EL (title number SYK462457), (“property”) or any part thereof including, without limitation, service charge and insurance payments (whether such tenant’s tenancy or licensee’s licence be express, implied or by operation of law) and any other income in respect of the property whatsoever but excluding any value added tax on such sums.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 hartshead square, sheffield t/n SYK446227, l/h properties k/a 1 hartshead square, sheffield t/n SYK427511 and lower ground floor, part upper ground floor, part ground, first, second and third floors and the multi-storey car park forming part of churchill house, sheffield t/n SYK462382 for details of further properties charged please refer to form 395. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 to 13 (odd) angel street, sheffield (also k/a 1 hartshead square, sheffield) t/no. SYK446227 and l/h property k/a 1 hartshead square, sheffield t/no. SYK427511; l/h property k/a part of the lower ground floor, upper ground floor, first floor, second floor and third floor and levels 1 to 7 multi storey car park forming part of churchill house t/no. SYK462382 and l/h property k/a part upper ground floor at meeting house leval and entrance lobby at campo lane/hartshead level, churchill house, meeting house lane, sheffield and a floating charge, the assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Charles Colin Wade, Jemima Elizabeth Wade and Barnett Waddingham Trustees Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 2003
    Consegnato il 12 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All leasehold property known as part upper ground floor at meeting house lane level and entrance lobby at campo lane hartshead level churchill house meeting house lane sheffield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charles Colin Wade Jemima Elizabeth Wade and Barnett Waddingham Trustees Liited
    Transazioni
    • 12 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 27 gen 2003
    Consegnato il 04 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to each finance party and each finance document under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/Hold property known as part upper ground floor at meeting house lane level and entrance lobby at campo lane,hartshead level,churchill house,meeting house lane with all benefits in respect of insurances and all claims and returns of premiums; all rights under any hedging arrangements and each lease document,both as defined; the benefit of licences,consents and interest in all rental income; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,as Agent and Trustee for Eachfinance Party
    Transazioni
    • 04 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 feb 2002
    Consegnato il 11 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) ("agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 to 13 (odd) angel street sheffield (also k/a 1 hartshead square sheffield part of t/no: SYK380887 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transazioni
    • 11 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 2002
    Consegnato il 01 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    No. 1 hartshead square t/no: SYK380887. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Wade Directors' Pension Scheme Being Charles Colin Wade and Jemimaelizabeth Wade and Barnett Waddingham Trustees Limited
    Transazioni
    • 01 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 2001
    Consegnato il 20 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All and any moneys, obligations and liabilities due owing or incurred by the company, as general partner of the hartshead square development partnership, to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 1 hartshead square sheffield t/n SYK427511 and l/h lower ground, upper ground, first, second and third floors of churchill house sheffield. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HARTSHEAD (GENERAL) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 ott 2016Inizio dell'amministrazione
    05 ott 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    2
    DataTipo
    15 ott 2019Data di scioglimento
    05 ott 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0