HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED

HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03981892
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JAMES HARVARD FINANCIAL LIMITED 10 feb 200410 feb 2004
    JAMES HARVARD INTERNATIONAL LIMITED27 apr 200027 apr 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 apr 2019

    32 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    32 pagineLIQ13

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 250 Euston Road London NW1 2AF a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 25 giu 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mag 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Paul Venables come amministratore in data 11 mag 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    5 pagineRP04CS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    Note
    DataNota
    20 giu 2017Clarification A SECOND FILED CS01 (PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL) WAS REGISTERED ON 20/06/2017.

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    4 pagineAA

    Nomina di Mr John Harrington come amministratore in data 28 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Ian Stamper come amministratore in data 28 gen 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2015

    Stato del capitale al 08 ott 2015

    • Capitale: GBP 80
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ott 2014

    Stato del capitale al 15 ott 2014

    • Capitale: GBP 80
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2013

    Stato del capitale al 02 ott 2013

    • Capitale: GBP 80
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYS NOMINEES LIMITED
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Segretario
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3981892
    100317500002
    HARRINGTON, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish204721550001
    BORT, Stefan Edward
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Segretario
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    British32824200011
    BROADFOOT, Victoria
    8 Glencoe Mansions
    Mowl Street
    SW9 0ER London
    Segretario
    8 Glencoe Mansions
    Mowl Street
    SW9 0ER London
    British90446930001
    MURTON, Sonia
    Bartley Mill Cottage
    Bartley Mill Road Little Bayham
    TN3 8BH Lamberhurst
    East Sussex
    Segretario
    Bartley Mill Cottage
    Bartley Mill Road Little Bayham
    TN3 8BH Lamberhurst
    East Sussex
    British46039000004
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BEEKE, Paul
    Unit 623 21 Wormwood Street
    Boston
    Ma 002210
    Usa
    Amministratore
    Unit 623 21 Wormwood Street
    Boston
    Ma 002210
    Usa
    British77548950003
    BROADFOOT, Victoria
    8 Glencoe Mansions
    Mowl Street
    SW9 0ER London
    Amministratore
    8 Glencoe Mansions
    Mowl Street
    SW9 0ER London
    British90446930001
    DUQUENOY, Philip James
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    Amministratore
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    EnglandBritish96824460001
    DUQUENOY, Philip James
    71 Bray Road
    GU2 7LJ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    71 Bray Road
    GU2 7LJ Guildford
    Surrey
    EnglandBritish96824460001
    HOLMES, Mark Walter James
    57a Cobden Road
    TN13 3UB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    57a Cobden Road
    TN13 3UB Sevenoaks
    Kent
    British70286390001
    JACKSON, Richard
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    Amministratore
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United KingdomBritish120037780002
    KEBBELL, Nicholas
    North Cottage
    Langton Road Langton Green
    TN3 0BB Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    North Cottage
    Langton Road Langton Green
    TN3 0BB Tunbridge Wells
    Kent
    British84097270001
    MCRAE, Andrew James
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    Amministratore
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    British2890800005
    MURTON, Andrew David
    Bartley Mill Cottage
    Little Bayham
    TN3 8BH Lamberhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Bartley Mill Cottage
    Little Bayham
    TN3 8BH Lamberhurst
    East Sussex
    British73121540001
    ROGERS, Stewart James
    White Lodge 3 Southlea Road
    SL3 9BY Datchet
    Berkshire
    Amministratore
    White Lodge 3 Southlea Road
    SL3 9BY Datchet
    Berkshire
    United KingdomBritish57367070001
    SCHIEMER, Bernard Keith
    Flat 3
    19 Broadwater Down
    TN2 5NJ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Flat 3
    19 Broadwater Down
    TN2 5NJ Tunbridge Wells
    Kent
    Austrailian70286340002
    STAMPER, Christopher Ian
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    Amministratore
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    EnglandBritish154777820001
    VENABLES, Paul
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    Amministratore
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United KingdomBritish103911420006
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4930093
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 nov 2005
    Consegnato il 10 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Asset Management Limited as Trustee for the Security Beneficiaries (The Securitytrustee)
    Transazioni
    • 10 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 ago 2005
    Consegnato il 23 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 mar 2004
    Consegnato il 31 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 31 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 set 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £8,500 plus an amount equivalent to vat thereon.
    Persone aventi diritto
    • Holborn Hall Limited
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 27 apr 2001
    Consegnato il 09 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee ("the security holder") in accordance with the terms of the transaction, security, instrument or other obligation including those under the financing agreement (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 ago 2000
    Consegnato il 19 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease
    Brevi particolari
    All sums from time to time constituting the security deposit and any additional sums paid into the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Roger Green
    Transazioni
    • 19 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge on book debts
    Creato il 03 ago 2000
    Consegnato il 04 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement dated 12TH july 2000 (as therein defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed charge all specified debts being any book debts (purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement) the ownership of which fail to vest in the chargee for any reason together with the related rights pertaining to such book debts, all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time owing to the company on any account whatsoever (together with the related rights) other than specified debts, floating charge such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Persone aventi diritto
    • First National Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2018Inizio della liquidazione
    26 lug 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0