DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED

DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03983245
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Creechurch Place
    EC3A 5AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PANGBORN HOWDEN LIMITED02 giu 200002 giu 2000
    DUAL DENMARK LIMITED28 apr 200028 apr 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Mark Andrew Hudson come amministratore in data 01 set 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr William David Bloomer come amministratore in data 01 set 2020

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 11/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Paul Andrew Ferris come amministratore in data 11 dic 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Damien Peter Coates come amministratore in data 11 dic 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2018

    15 pagineAA

    legacy

    99 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Modifica dei dettagli di Dual International Limited come persona con controllo significativo il 01 gen 2019

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Damien Peter Coates il 01 gen 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Andrew Ferris il 01 gen 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Malcolm Clapham il 01 gen 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Andrew Hudson il 01 gen 2019

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da First Floor Bankside House 107-112 Leadenhall Street London EC3A 4AF a One Creechurch Place London EC3A 5AF in data 02 gen 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Andrew John
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    Segretario
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    197508470001
    BLOOMER, William David
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    Amministratore
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish214179860002
    CLAPHAM, Richard Malcolm
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    Amministratore
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish207768150001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Segretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    187895240001
    PALLOT, Hugh Glen
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    Segretario
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    British14485660002
    PIGRAM, Ivor
    93 Kingsfield Road
    Oxhey
    WD19 4TP Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    93 Kingsfield Road
    Oxhey
    WD19 4TP Watford
    Hertfordshire
    British993440001
    SNOOKS, Emma Louise
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Segretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    187895250001
    COATES, Damien Peter
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    Amministratore
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    AustraliaAustralian130710660002
    CROWTHER, Stephen Joseph
    Sundial House
    Maddox Lane Bookham
    KT23 3BS Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Sundial House
    Maddox Lane Bookham
    KT23 3BS Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish33086310007
    DOYLE, Shane Peter
    107-112 Leadenhall Street
    EC3A 4AF London
    First Floor Bankside House
    United Kingdom
    Amministratore
    107-112 Leadenhall Street
    EC3A 4AF London
    First Floor Bankside House
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealand171227070002
    ELSTON, Andrew Henry
    Stoke Row Road
    Peppard Common
    RG9 5JD Henley On Thames
    Stamford House
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Stoke Row Road
    Peppard Common
    RG9 5JD Henley On Thames
    Stamford House
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish190072960001
    FARMER, Paul Robert
    10 Braintree Road
    CM8 2DD Witham
    Essex
    Amministratore
    10 Braintree Road
    CM8 2DD Witham
    Essex
    United KingdomBritish46071820001
    FERRIS, Paul Andrew
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    Amministratore
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish102254120001
    GERRY, James Thomas
    Old Barn Road
    Mount Bures
    CO8 5AH Bures
    The Old Rectory
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Barn Road
    Mount Bures
    CO8 5AH Bures
    The Old Rectory
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish135992430001
    GIESON, Robert Thomas Van
    Bevis Marks
    EC3A 7JB London
    24
    Amministratore
    Bevis Marks
    EC3A 7JB London
    24
    United KingdomUnited States140091160002
    HOWDEN, David Philip
    The Old Rectory
    Brill Road Ludgershall
    HP18 9PG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Brill Road Ludgershall
    HP18 9PG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish75271140001
    HUDSON, Mark Andrew
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    Amministratore
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish67260770004
    MUNOZ - ROJAS ENTRECANALES, Luis
    32 Sil Street
    FOREIGN 28002 Madrid
    Spain
    Amministratore
    32 Sil Street
    FOREIGN 28002 Madrid
    Spain
    Spanish115153830001
    PATEL, Rinku
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Amministratore
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    EnglandBritish101324520002
    PRATT, Gordon Robert
    11 Northpoint
    Sherman Road
    BR1 3JN Bromley
    Kent
    Amministratore
    11 Northpoint
    Sherman Road
    BR1 3JN Bromley
    Kent
    British104541200002
    SMITH, Alan
    The Croft
    Green Lane Ardleigh
    CO7 7PB Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Croft
    Green Lane Ardleigh
    CO7 7PB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish62859550001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    06 giu 2016
    EC3A 5AF London
    One Creechurch Place
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3540129
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DUAL OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 apr 2015
    Consegnato il 13 mag 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
    Transazioni
    • 13 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 dic 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 16 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 apr 2015
    Consegnato il 12 mag 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
    Transazioni
    • 12 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 dic 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 16 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 apr 2015
    Consegnato il 06 mag 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All intellectual property, meaning any patent, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, etc. and the benefit of all applications and rights to use such assets of each chargor.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
    Transazioni
    • 06 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 mag 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 ott 2013
    Consegnato il 04 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (And Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 04 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 ott 2013
    Consegnato il 04 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (And Its Successors in Title Permitted Assignees and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 04 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 ott 2013
    Consegnato il 04 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (And Its Successors in Title Permitted Assignees and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 04 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 02 ago 2012
    Consegnato il 15 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral, being- the present security, any after-acquired security and any new rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Specific security deed
    Creato il 02 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    187,500 ordinary shares in dual new zealand limited, together with any additional shares; all of the rights.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 31 mag 2012
    Consegnato il 08 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 giu 2009
    Consegnato il 10 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3 I Group PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 03 giu 2009
    Consegnato il 09 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor named therein to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • B.P. Marsh & Company Limited as Security Trustee for the Lenders (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 05 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0