SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED

SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03998112
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Henkel Limited
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAMSARD 2200 LIMITED19 mag 200019 mag 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Application to strike off 03/05/2023
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Peter David Budden come amministratore in data 10 gen 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Liam Anthony Murphy come amministratore in data 10 gen 2023

    1 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2015

    Stato del capitale al 19 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Apollo Court 2 Bishop Square Business Park Hatfield Herts AL10 9EY a Henkel Limited Wood Lane End Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4RQ in data 23 lug 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2014

    Stato del capitale al 19 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter David Budden il 21 gen 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Sutinder Bhandal come segretario

    3 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di David Graham come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BHANDAL, Sutinder
    Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    5
    Warwickshire
    Uk
    Segretario
    Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    5
    Warwickshire
    Uk
    British174260500001
    BHANDAL, Sutinder Singh
    5 Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    5 Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish113815020001
    GRAHAM, David Richard
    32 Monkhams Lane
    IG8 0NS Woodford Green
    Essex
    Segretario
    32 Monkhams Lane
    IG8 0NS Woodford Green
    Essex
    British7345980001
    STEWARD, Andrew
    8 Carrion View
    S81 8YZ Gateford
    Nottinghamshire
    Segretario
    8 Carrion View
    S81 8YZ Gateford
    Nottinghamshire
    British73836180002
    BUDDEN, Peter David
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Henkel Limited
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Henkel Limited
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish114395690003
    CORK, James William
    1 Marlborough Court
    NG24 4PT Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    1 Marlborough Court
    NG24 4PT Newark
    Nottinghamshire
    British73836260001
    COVALT, Robert Byron
    7517 West Bull Valley
    Road
    Mchenry
    Illinois 60050
    Usa
    Amministratore
    7517 West Bull Valley
    Road
    Mchenry
    Illinois 60050
    Usa
    American5288740001
    HOWELL JONES, Martin
    3 Peacock Court
    20 South Park Road
    SW19 8SX Wimbledon
    Amministratore
    3 Peacock Court
    20 South Park Road
    SW19 8SX Wimbledon
    EnglandBritish79974450001
    JARVIS, Timothy Hugh
    2 Park Lane
    LS3 1ES Leeds
    Amministratore
    2 Park Lane
    LS3 1ES Leeds
    British72690800001
    MEIER, Anke
    Simon Meister Strasse 13
    50733 Cologne
    Germany
    Amministratore
    Simon Meister Strasse 13
    50733 Cologne
    Germany
    British95320690002
    MURPHY, Liam Anthony
    St Joseph's Avenue
    Station Road
    IRISH Newbridge
    County Kildare
    Ireland
    Amministratore
    St Joseph's Avenue
    Station Road
    IRISH Newbridge
    County Kildare
    Ireland
    IrelandIrish95686630001
    PACE, Louis Michael
    2607 W Huron Street
    FOREIGN Chicago
    60612 Illinois
    Usa
    Amministratore
    2607 W Huron Street
    FOREIGN Chicago
    60612 Illinois
    Usa
    American72627550002
    SMITH, Terry Dan
    155 Samoa Drive
    Akron
    Ohio 44319
    United States
    Amministratore
    155 Samoa Drive
    Akron
    Ohio 44319
    United States
    United StatesAmerican164946460001
    HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Amministratore delegato nominato
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008740001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Amministratore delegato nominato
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008750001

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 26 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jp Morgan Chase Bank as Security Trustee for the Secured Parties (The "Administrative Agent")
    Transazioni
    • 26 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 30 nov 2000
    Consegnato il 11 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and obligations due from the company to the chargee and/or the secured parties under the credit agreement and other loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    185 registered shares of the company numbered from 1 to 185 (the shares) any dividends and any other monies which would be due to the holder of the shares.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank the (Administrative Agent) as Security Trustee Foritself and the Other Agents Lender Parties and Hedge Banks Banks (as Defined)
    Transazioni
    • 11 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Quota pledge agreement
    Creato il 24 nov 2000
    Consegnato il 11 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us$93,587.00 Which amount was borrowed by the company from the lenders and advanced to the company as an intercompany loan to fund the company's purchase of certain assets of croda italiana spa as part of the croda acquisition as defined
    Brevi particolari
    A continuing first priority security interest in and to all of the right title and interest of the pledgor in the quotas under clause 2 of the pledge under clause 5 of the pledge it was agreed that the pledge constitutes a continuing security to the pledgee for the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank for Its Own Account and on Behalf of Certainlenders
    Transazioni
    • 11 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2000
    Consegnato il 08 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured parties and/or any reciever under or in connection with the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bankthe ("Administrative Agent") as Security Trustee for Itself and the Other Agents, Lender Parties and Hedge Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 08 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0