RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED

RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04005268
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hunter House
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al25 mag 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il25 feb 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 mag 2022
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 giu 2022
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 mag 2021
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2025

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2024

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2023

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2022

    13 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 167-169 5th Floor Great Portland Street London W1W 5PF England a Hunter House 109 Snakes Lane West Woodford Green Essex IG8 0DY in data 16 set 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 set 2021

    LRESEX

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 9, 2nd Floor Crystal House New Bedford Road Luton LU1 1HS England a 167-169 5th Floor Great Portland Street London W1W 5PF in data 27 mag 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2020

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2019

    11 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 26 mag 2019 al 25 mag 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Peter David Joy come amministratore in data 20 gen 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Stockwood Suite a Britannia House Leagrave Road Luton LU3 1RJ England a Suite 9, 2nd Floor Crystal House New Bedford Road Luton LU1 1HS in data 24 mag 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2018

    11 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 27 mag 2018 al 26 mag 2018

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JOY, Peter David
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Hunter House
    Essex
    Segretario
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Hunter House
    Essex
    185918550001
    DE HAAN, Joshua
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Hunter House
    Essex
    Amministratore
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Hunter House
    Essex
    EnglandBritish130378010002
    DALEY, Janet
    64 The Terrace
    DA12 2BB Gravesend
    Kent
    Segretario
    64 The Terrace
    DA12 2BB Gravesend
    Kent
    BritishPersonal Assistant110020290001
    DE HAAN, Benjamin
    Park House Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    Park House Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British43305510003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DALEY, Janet
    64 The Terrace
    DA12 2BB Gravesend
    Kent
    Amministratore
    64 The Terrace
    DA12 2BB Gravesend
    Kent
    United KingdomBritishPersonal Assistant110020290001
    DE HAAN, Benjamin
    Park House Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    Park House Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishDirector43305510003
    DE HAAN, Joshua
    Flat 4 Martin House
    179-181 North End Road
    W14 9LL London
    Amministratore
    Flat 4 Martin House
    179-181 North End Road
    W14 9LL London
    United KingdomBritishDirector100282210001
    JOY, Peter David
    Crystal House
    New Bedford Road
    LU1 1HS Luton
    Suite 9, 2nd Floor
    England
    Amministratore
    Crystal House
    New Bedford Road
    LU1 1HS Luton
    Suite 9, 2nd Floor
    England
    EnglandBritishBook Keeper42741760002
    MURTAGH, Simon Peter
    84 Rochester Street
    ME4 6RR Chatham
    Kent
    Amministratore
    84 Rochester Street
    ME4 6RR Chatham
    Kent
    BritishManager43398320001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Lesley Ann De Haan
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Hunter House
    Essex
    31 mag 2017
    109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Hunter House
    Essex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 28 mag 2012
    Consegnato il 31 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all its interest in the account and the deposit blance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knighton Estates Limited
    Transazioni
    • 31 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 ago 2011
    Consegnato il 15 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its interest in the account and deposit balance.
    Persone aventi diritto
    • Knighton Estates Limited
    Transazioni
    • 15 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2011
    Consegnato il 02 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and book debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Oakbridge Estates LTD
    Transazioni
    • 02 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2011
    Consegnato il 02 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Retail Space Management (London) LTD
    Transazioni
    • 02 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2011
    Consegnato il 02 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Benjamin De Haan
    Transazioni
    • 02 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 17 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £6,205.00 plus a sum equivalent to the value added tax at a rate of 17.5 % on that amount in the sum of £1,085.88.
    Persone aventi diritto
    • Ls Park House Limited
    Transazioni
    • 17 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £42,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Duchess Properties Limited and Sovreign Properties Limited
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 15 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £11,750.
    Persone aventi diritto
    • Tr Property Investment Trust PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent security deposit deed
    Creato il 17 mag 2004
    Consegnato il 18 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,110.00 including vat due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The interest in the deposit (being the sum of £6,110.00 including vat together with any interest earned thereon).
    Persone aventi diritto
    • Bow Bells House Investment G-1 Limited and Bow Bells House Investment G-2 Limited
    Transazioni
    • 18 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 13 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £11,750 together with all interest thereon being the amount standing to the credit of retail space management limited account or such sums standing to the credit of the said account.
    Persone aventi diritto
    • Tr Property Investment Trust PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 ago 2002
    Consegnato il 28 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being £15,275.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Cook Retail Limited
    Transazioni
    • 28 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 10 giu 2002
    Consegnato il 14 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A seperate interest bearing designated call deposit account in the name of the landlord's managing agents pilcher hershman re: retail space management limited rent deposit account containing £33,605 or such funds as may from time to time stand to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Property Developments Limited
    Transazioni
    • 14 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    RETAIL SPACE MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 set 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Zain Iqbal
    Hunter House 109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Essex
    Praticante
    Hunter House 109 Snakes Lane West
    IG8 0DY Woodford Green
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0