MASTERNAUT UK LIMITED

MASTERNAUT UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMASTERNAUT UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04006118
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MASTERNAUT UK LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova MASTERNAUT UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MASTERNAUT UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIVE REPLY LIMITED22 dic 200022 dic 2000
    LIVEREPLY LIMITED01 giu 200001 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di MASTERNAUT UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MASTERNAUT UK LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MASTERNAUT UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2014

    12 pagine4.68

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 18 nov 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da Priory Park Great North Road Aberford Leeds West Yorkshire LS25 3DF in data 04 ott 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Cessazione della carica di Djamel Souici come segretario in data 15 lug 2013

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Samantha Gray come segretario in data 15 lug 2013

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Martin Andrew Hiscox come amministratore in data 15 lug 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 giu 2013

    Stato del capitale al 04 giu 2013

    • Capitale: GBP 1,821
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Martin Hiscox come amministratore in data 12 mar 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Samantha Gray come segretario in data 12 mar 2012

    1 pagineAP03

    Nomina di Djamel Souici come segretario in data 12 mar 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nicholas Williams come amministratore in data 19 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Masternaut International Sas come amministratore in data 19 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Patrick Henry come amministratore in data 13 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Laurent Favre come amministratore in data 19 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Keith Waterhouse come segretario in data 12 mar 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Paul Francis Bosson come amministratore in data 12 mar 2012

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MASTERNAUT UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOSSON, Paul Francis
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Amministratore
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish82707040001
    BELLAMY, Simon James
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British95804040002
    GRAY, Samantha
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    167961000001
    GREEN, Marlene
    22 Sandmoor Drive
    Alwoodley
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    22 Sandmoor Drive
    Alwoodley
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4923560001
    SOUICI, Djamel
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    167960970001
    WATERHOUSE, Paul Keith
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    149708760001
    QA REGISTRARS LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018500001
    BELLAMY, Simon James
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish95804040002
    DE PESCARA, Christophe
    c/o Hub Telecom
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    Roissy
    Le Dome
    France
    Amministratore
    c/o Hub Telecom
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    Roissy
    Le Dome
    France
    FranceFrench155158600001
    DUPEYRON, Frederic
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy Cdg
    Hub Telecom, Le Dome
    France
    Amministratore
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy Cdg
    Hub Telecom, Le Dome
    France
    FranceFrench147497520002
    FAVRE, Laurent
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy Cdg
    Hub Telecom, Le Dome
    France
    Amministratore
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy Cdg
    Hub Telecom, Le Dome
    France
    FranceFrench124399110001
    GREEN, Ivan Henry
    22 Sandmoor Drive
    Alwoodley
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    22 Sandmoor Drive
    Alwoodley
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4923580001
    HENRY, William Patrick
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    United KingdomAmerican159943040001
    HISCOX, Martin Andrew
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish167954460001
    LANNE, Michel Marc
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomFrench149709490002
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish169886380001
    PORT, Martin Harry
    Wigton Lane
    LS17 8SJ Leeds
    52
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wigton Lane
    LS17 8SJ Leeds
    52
    West Yorkshire
    EnglandBritish84002050001
    WILLIAMS, Nicholas
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Priory Park Great North Road
    Aberford
    LS25 3DF Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish160931630001
    MASTERNAUT INTERNATIONAL SAS
    Rue Charles Cros
    27400 Louvier
    4
    France
    Amministratore
    Rue Charles Cros
    27400 Louvier
    4
    France
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione417 555 430
    147541800001
    QA NOMINEES LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018490001

    MASTERNAUT UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 15 apr 2011
    Consegnato il 21 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Full title guarantee all stock shares bonds debentures stock investments all dividends all cash see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 15 apr 2011
    Consegnato il 21 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Schedule to the master charge
    Creato il 15 apr 2009
    Consegnato il 17 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged equipment, all proceeds of sale, all insurance monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bond Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 17 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Schedule to master charge
    Creato il 20 mag 2008
    Consegnato il 07 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest of the charged equipment, all proceeds of sale, all insurance monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bond Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 feb 2008
    Consegnato il 26 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account assignment and charge agreement
    Creato il 25 giu 2007
    Consegnato il 06 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies from time to time credited and for the time being standing to the credit of the collection account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hitachi Capital (UK) PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Schedule to master charge
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 21 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment all proceeds of sale or other disposition of the equipment comprised in the lease agreements all insurnace monies receivable in respect of damage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bond Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment and charge
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 07 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The products as defined in the assignment and charge and all right, title and interest in relation to the products and to the lease agreements, all monies under or arising out of the lease agreement and all claims for damages in respect of breach of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Equipment Finance Limited
    Transazioni
    • 07 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Schedule to master charge dated 19TH december 2005 and
    Creato il 26 apr 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company's right, title and interest in the equipment relating to the agreement number mnl 412. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Schedule to master charge dated 19TH december 2005 and
    Creato il 26 apr 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company's right, title and interest in the equipment relating to the agreement number mnl 417. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Schedule to master charge dated 19TH december 2005
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 18 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The right title and interest in the equipment relating to agreement number MNL386 dated 20TH march 2006 made between the company and east ayrshire county council, all monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment and charge
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 11 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The products and all of the companys right title and interest in relation to the products and to the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 ott 2004
    Consegnato il 28 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MASTERNAUT UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 set 2013Inizio della liquidazione
    02 mag 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Paul Grant
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Praticante
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Anthony Malcolm Cork
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Praticante
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0