PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED

PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04008909
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al24 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB in data 23 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 nov 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 24 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 giu 2012

    Stato del capitale al 06 giu 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 24 dic 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 24 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Brian Watt il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Graham Paine il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew John Jackson il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Michael Hannigan il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 24 dic 2008

    8 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Paolo Alonzi il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALONZI, Paolo
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Segretario
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Italian113225330001
    HANNIGAN, Robert Michael
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish81510590004
    JACKSON, Andrew John
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish83130180001
    PAINE, David Graham
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritish79124040001
    WATT, Mark Brian
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish85845500002
    CATTERALL, Nicola Jane
    Old Stonelaws House
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Segretario
    Old Stonelaws House
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    British94975930001
    EVANS, Michael
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    Segretario
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    British98652120001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Segretario
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    MAHENDRA, Myron Murugendra
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    Segretario
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    British62660140005
    REITH, Julie Katharine
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    British112039220001
    TABERNER, Susan
    9 Hillside
    BL1 5DT Bolton
    Lancashire
    Segretario
    9 Hillside
    BL1 5DT Bolton
    Lancashire
    British96933410001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    St James's Buildings, 79 Oxford Street
    M1 6FR Manchester
    Segretario
    The Britannia Suite
    St James's Buildings, 79 Oxford Street
    M1 6FR Manchester
    83758610001
    ALONZI, Paolo
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomItalian113225330001
    BARRY, Desmond Joseph William
    9 Tiffany Close
    RG41 3BN Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Tiffany Close
    RG41 3BN Wokingham
    Berkshire
    British27098090001
    EARLY, John Dalton
    Flat 510 Middle Warehouse
    Castle Quay Chester Road
    M15 4NT Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Flat 510 Middle Warehouse
    Castle Quay Chester Road
    M15 4NT Manchester
    Lancashire
    British4150930005
    FRITH, Brian
    Chapelle Des Landes
    Le Mont Des Landes
    JE3 6DJ St Martin
    Jersey
    Amministratore
    Chapelle Des Landes
    Le Mont Des Landes
    JE3 6DJ St Martin
    Jersey
    JerseyBritish72410440001
    JOHNSON, Andrew William
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish68089410003
    MCGUIRE, Martin Anton
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish46513600001
    MELHUISH, Richard Marcus
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    British83530000001
    O'BRIEN, Daniel Terence
    47 Willowmead Drive
    Prestbury
    SK10 4DD Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    47 Willowmead Drive
    Prestbury
    SK10 4DD Macclesfield
    Cheshire
    British52052530001
    RUSSO, Onofrio
    8 Stormont Road
    N6 4NL London
    Amministratore
    8 Stormont Road
    N6 4NL London
    Italian53349910001
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    32732300001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each relevant company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first legal mortgage (1) all the property and (2) all estates or interests in any f/h or l/h property now or hereafter belonging to that chargor; the l/h land k/a burger king, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA891842 and l/h land k/a b&q premises, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA870380. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each relevant company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first legal mortgage (1) all the property and (2) all estates or interests in any f/h or l/h property now or hereafter belonging to that chargor; the l/h land k/a burger king, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA891842 and l/h land k/a b&q premises, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA870380. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 07 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The leasehold properties known as the burger king premises and the b & q premises.
    Persone aventi diritto
    • Primequota Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 giu 2001
    Consegnato il 22 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the leasehold land known as the burger king site lostock lane bamber bridge preston lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over collateral warranties
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 07 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's interest in the eight collateral warranties relating to the development of a retail warehouse at bamber bridge preston lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over development agreement
    Creato il 23 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's interest in two development agreements dated 30/6/2000,as defined,with all rights,titles and benefits thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over agreement for lease
    Creato il 23 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's interest in the two agreements dated 3/4/98 and 13/6/2000,as defined,with all rights,titles,benefits and interests thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold land comprised in a lease dated 8/6/2000 known as b and q site,lostock lane,bamber bridge,preston,lancs. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2012Inizio della liquidazione
    07 apr 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0