EGS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEGS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04016499
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EGS GROUP LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione
    • Portali web (63120) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova EGS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EGS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    E-GOVERNMENT SOLUTIONS (UK) LIMITED05 ott 200005 ott 2000
    PRECIS (1911) LIMITED16 giu 200016 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di EGS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per EGS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2021

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 040164990015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040164990014 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2020

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Sean Anthony Mcdonough come amministratore in data 30 set 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 lug 2019

    15 pagineAA

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 040164990014

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 040164990015

    1 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Richard Gareth Hughes come amministratore in data 20 mag 2019

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 apr 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 lug 2018

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di George Hampton Wall, Jr come amministratore in data 09 gen 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 lug 2017

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EGS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SYKES, Timothy James
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    185152220001
    HUGHES, Richard Gareth
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    Amministratore
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    EnglandBritish259234800001
    SYKES, Timothy James
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134824900001
    BARCLAY, Lisa Megan
    27 Haverstock Street
    N1 8DL London
    Segretario
    27 Haverstock Street
    N1 8DL London
    British76453470001
    BISHOP, Robert Ludo James
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    Segretario
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    Canadian71964950001
    CRAGNOLINI, Adriano
    Flat 12
    8 Penywern Road
    SW5 9ST London
    Segretario
    Flat 12
    8 Penywern Road
    SW5 9ST London
    Australian86619610002
    DEARY, Brendan Francis
    Baird House
    15-17 Saint Cross Street
    EC1N 8UW London
    Segretario
    Baird House
    15-17 Saint Cross Street
    EC1N 8UW London
    162427050001
    DONNELLY, Thomas Patrick
    10 Anerley House
    20 Princes Square
    W2 4NP London
    Segretario
    10 Anerley House
    20 Princes Square
    W2 4NP London
    British81215910001
    ENRIGHT, Michael John
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    Segretario
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    British73670210003
    GREEN, Peter David Andrew
    Corringham Road
    NW11 7BU London
    30
    United Kingdom
    Segretario
    Corringham Road
    NW11 7BU London
    30
    United Kingdom
    British139608500001
    JONES, Howard Jeffrey
    31 Downs Court Road
    CR8 1BF Purley
    Surrey
    Segretario
    31 Downs Court Road
    CR8 1BF Purley
    Surrey
    British123226640001
    KELLY, Martyn Paul
    3 Meadow Close
    TN13 3HZ Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    3 Meadow Close
    TN13 3HZ Sevenoaks
    Kent
    British29274620001
    TOMA, Elena
    Baird House
    15-17 Saint Cross Street
    EC1N 8UW London
    Segretario
    Baird House
    15-17 Saint Cross Street
    EC1N 8UW London
    172869310001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Segretario nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARCLAY, Lisa Megan
    27 Haverstock Street
    N1 8DL London
    Amministratore
    27 Haverstock Street
    N1 8DL London
    British76453470001
    BISHOP, Robert Ludo James
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    Amministratore
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    Canadian71964950001
    BUSBY, Ian Christopher
    40 Latimer Road
    Headington
    OX3 7PF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    40 Latimer Road
    Headington
    OX3 7PF Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish77686270002
    ELLIS, Jeremy Colin Dupont
    48 Overstrand Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4EY London
    Amministratore
    48 Overstrand Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4EY London
    United KingdomBritish87784750002
    ENRIGHT, Michael John
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    Amministratore
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    United KingdomBritish73670210003
    FRASER, Jeffrey Scott
    PO BOX 1550
    Wilson
    Wyoming 83014
    Usa
    Amministratore
    PO BOX 1550
    Wilson
    Wyoming 83014
    Usa
    American74029340001
    GIBSON, Adrian George
    Baird House
    15-17 Saint Cross Street
    EC1N 8UW London
    Amministratore
    Baird House
    15-17 Saint Cross Street
    EC1N 8UW London
    EnglandBritish176478730001
    JONES, Rodney Desmond
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    WalesBritish82816570003
    MATHUR, Piyush
    Shannon Place
    NW8 7DN London
    58 Eamont Court
    Amministratore
    Shannon Place
    NW8 7DN London
    58 Eamont Court
    United KingdomIndian130337570001
    MCDONOUGH, Sean Anthony
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    Amministratore
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    EnglandBritish83191640003
    MITCHELL, Jamie Matthew
    510 Royle Building
    Wenlock Road
    N1 7SH London
    Amministratore
    510 Royle Building
    Wenlock Road
    N1 7SH London
    United KingdomBritish65275190003
    STANDER III, Henricus Johannus
    150 East 72nd Street
    5c
    NY 10021 New York
    New York
    Usa
    Amministratore
    150 East 72nd Street
    5c
    NY 10021 New York
    New York
    Usa
    American72426850001
    WALL JR, George Hampton
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    Amministratore
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United StatesAmerican239423450001
    WHENT, Peter John
    Chapel Lane
    SP11 8JP Grateley
    Grateley Lodge
    Hampshire
    Amministratore
    Chapel Lane
    SP11 8JP Grateley
    Grateley Lodge
    Hampshire
    United KingdomBritish131769110001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Amministratore delegato nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EGS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Egs Group Holdings Ltd
    1 Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    Riverview Court
    England
    16 giu 2017
    1 Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    Riverview Court
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione04006942
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EGS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 07 lug 2017
    Consegnato il 12 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Software module: content management (for further details, please see schedule 1 of the charge document).. For details of further intellectual property, please refer to the charge document.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 set 2019Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 10 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 feb 2014
    Consegnato il 26 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 set 2019Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 10 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Barry-Walsh
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter Whent
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Katherine Ellis
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 apr 2010
    Consegnato il 07 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in the account and the deposit balance from time to time and all money from time to time withdrawn from the account.
    Persone aventi diritto
    • Middlesex Securities Limited
    Transazioni
    • 07 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2010
    Consegnato il 06 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £85,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cabris Consulting Limited
    Transazioni
    • 06 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2010
    Consegnato il 06 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £115,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jerry Ellis
    Transazioni
    • 06 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2010
    Consegnato il 06 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £26,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter Whent
    Transazioni
    • 06 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 giu 2009
    Consegnato il 08 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jerry Ellis
    Transazioni
    • 08 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 ago 2007
    Consegnato il 18 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bms Finance Ab Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Trust debenture
    Creato il 10 ago 2006
    Consegnato il 22 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Panmure Capital Paisner LLP
    • Panmure Capital Paisner LLP
    Transazioni
    • 22 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 apr 2005
    Consegnato il 02 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,141.27 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company's interest in the account and the deposit balance,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbotts Properties Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 ott 2004
    Consegnato il 16 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 16 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The amount standing to the credit of a designated account initially £8,141.27.
    Persone aventi diritto
    • Haigside Limited
    Transazioni
    • 16 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0