VIZZAVI LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIZZAVI LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04017435
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIZZAVI LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VIZZAVI LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIZZAVI LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per VIZZAVI LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Janine Butler come amministratore in data 09 feb 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Michael Yorston come amministratore in data 09 feb 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Paul Mitchell come amministratore in data 09 feb 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Thurston Raggett come amministratore in data 09 feb 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Sugnet Pretorius come amministratore in data 09 feb 2022

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Nomina di Mrs Janine Butler come amministratore in data 23 feb 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Nigel Evans come amministratore in data 23 feb 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Michael Yorston come amministratore in data 02 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Diane Josephine Mcintyre come amministratore in data 16 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di VIZZAVI LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02357692
    75473330004
    MITCHELL, Jonathan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish243284220002
    PRETORIUS, Sugnet
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomSouth African284625720001
    RAGGETT, Andrew Thurston
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish200324290001
    HEATHER, Christopher Adrian
    Flat 5 2 Gainsford Street
    SE1 2NE London
    Segretario
    Flat 5 2 Gainsford Street
    SE1 2NE London
    British73697810001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    BOULBEN, Frank Joseph Maxime
    9 Rue Du Temple
    FOREIGN Paris
    75004
    France
    Amministratore
    9 Rue Du Temple
    FOREIGN Paris
    75004
    France
    French73697950001
    BRONFMAN JNR, Edgar
    375 Park Avenue
    New York
    Usa
    Amministratore
    375 Park Avenue
    New York
    Usa
    American48429280001
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    GEITNER, Thomas
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    German78550520002
    GENT, Christopher Charles, Sir
    Bockhampton Manor
    RG17 7LS Lambourn
    Berkshire
    Amministratore
    Bockhampton Manor
    RG17 7LS Lambourn
    Berkshire
    British50867930003
    GERMOND, Philippe
    2 Ter Rue D'Alsace Lorraine
    Boulogne
    92100
    France
    Amministratore
    2 Ter Rue D'Alsace Lorraine
    Boulogne
    92100
    France
    French67763260001
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British27272400002
    HORN-SMITH, Julian Michael, Sir
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United KingdomBritish102383880001
    ISAKSSON, Rolf Thomas
    56 Merrill Circle North
    Moraga
    Ca 94556
    Usa
    Amministratore
    56 Merrill Circle North
    Moraga
    Ca 94556
    Usa
    Swedish73922310001
    JOUSSEN, Friedrich Peter Johannes
    Lotharstrasse 117
    Duisberg
    47057
    Germany
    Amministratore
    Lotharstrasse 117
    Duisberg
    47057
    Germany
    GermanyGerman176065050001
    LAURENCE, Jonathan Guy
    SL9
    Amministratore
    SL9
    United KingdomBritish75160240003
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LESCURE, Pierre
    8 Avenue Raphael
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    Amministratore
    8 Avenue Raphael
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    French75863270002
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    MESSIER, Jean-Marie
    64 Boulevard De Courcelles
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    Amministratore
    64 Boulevard De Courcelles
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    French67570640003
    NEWMARK, Evan Michael
    67 Abingdon Villas
    W8 6XB London
    Amministratore
    67 Abingdon Villas
    W8 6XB London
    Usa73697900001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    RICHARDS, Clarke Stewart
    Applegarth Moor Lane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Applegarth Moor Lane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    British56522910002
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VIZZAVI LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2797438
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VIZZAVI LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 09 ott 2001
    Consegnato il 15 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of three million seven hundred and twenty nine thousand four hundred and twenty seven pounds sterling (3,729,427) together with all interest accured on the sum in the account referred to in the deed.
    Persone aventi diritto
    • Ivybridge Gp 1 Limited and Ivybridge Gp Limited Both as General Partners Under and for and on Behalf of the Ivybridge Investments Limited Partnership
    Transazioni
    • 15 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 ott 2001
    Consegnato il 15 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of three million seven hundred and twenty one thousand seven hundred and fifty five pounds sterling (£3,721,755) together with all interest accrued on the sum in the account referred to in the deed.
    Persone aventi diritto
    • Ivybridge Gp 1 Limited and Ivybridge Gp Limited Both as General Partners Under and for and on Behalf of the Ivybridge Investments Limited Partnership
    Transazioni
    • 15 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 25 set 2000
    Consegnato il 29 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from vizzavi limited (the principal debtor) to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Brevi particolari
    Fixed charge over all deposit(s) in charged account re;-vizzavi limited a/c 200000 B47380300. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed relating to rental deposit
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the underlease dated 22ND march 2000 defined therein relating to 19TH floor of the tower block forming part of the building shortly k/a the marble arch tower london W1
    Brevi particolari
    The capital monies and all accrued interest thereon standing to the credit of the designated deposit account in which the deposit of £134,685 with barclays bank PLC 155 bishopsgate london.
    Persone aventi diritto
    • Marble Arch Tower Limited
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0