TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED

TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04017551
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRAMBLEPOINT LIMITED20 giu 200020 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 01 lug 2015

    1 pagineCH02

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Dundas & Wilson Northwest Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF in data 01 lug 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2015

    Stato del capitale al 17 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Peter Ashbrook il 01 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Philip Peter Ashbrook come amministratore in data 25 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard David Hoile come amministratore in data 25 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2014

    Stato del capitale al 19 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Nomina di John Ivor Cavill come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard David Hoile come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Haga come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Biif Corporate Services Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Nigel Middleton come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Baldock come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Infrastructure Managers Limited il 26 feb 2013

    2 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Law Debenture Fifth Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX* in data 04 set 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Thomas Justin Haga come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05372427
    128530180002
    ASHBROOK, Philip Peter
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish121252960003
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish178845820001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06793845
    176421170001
    HILL, Gavin
    Pine Ridge House
    4 Bourne Grove Close Lower Bourne
    GU10 3RA Farnham
    Surrey
    Segretario
    Pine Ridge House
    4 Bourne Grove Close Lower Bourne
    GU10 3RA Farnham
    Surrey
    British84457250002
    MCCORMACK, Lisa
    21 Ellingham Road
    KT9 2JA Chessington
    Surrey
    Segretario
    21 Ellingham Road
    KT9 2JA Chessington
    Surrey
    British62627440001
    MOORE, William Edmond
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    British114630630002
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Segretario
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    UNSWORTH, John Warburton
    17 Lower Road
    HP22 5XA Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    Segretario
    17 Lower Road
    HP22 5XA Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    British99164650001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BALDOCK, Graham
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    United KingdomBritish49519600001
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Amministratore
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    United KingdomBritish56835390001
    CRAWSHAW, Andrew Julian
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    Amministratore
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    EnglandBritish130322170001
    DOWNIE, Ian Wilson
    Chapel Farm
    Gussage St Andrew
    DT11 8DL Blandford
    Dorset
    Amministratore
    Chapel Farm
    Gussage St Andrew
    DT11 8DL Blandford
    Dorset
    British35270820002
    FITZSIMMONS, Hugh
    1 Fawe Park Mews
    184a Fawe Park Road
    SW15 2EQ London
    Amministratore
    1 Fawe Park Mews
    184a Fawe Park Road
    SW15 2EQ London
    United KingdomBritish98931030001
    GIBSON, Darryn Stanley
    Flat 4
    179 Sutherland Avenue
    W9 1ET Maida Vale London
    Amministratore
    Flat 4
    179 Sutherland Avenue
    W9 1ET Maida Vale London
    New Zealander65690030002
    HAGA, Thomas Justin
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    United KingdomBritish111282640001
    HILL, Gavin
    Pine Ridge House
    4 Bourne Grove Close Lower Bourne
    GU10 3RA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Pine Ridge House
    4 Bourne Grove Close Lower Bourne
    GU10 3RA Farnham
    Surrey
    EnglandBritish84457250002
    HOILE, Richard David
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    United KingdomBritish137848430002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MANN, Alan Raymond
    Mariemont
    12 Ladyegate Road
    RH5 4AR Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Mariemont
    12 Ladyegate Road
    RH5 4AR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish42048960002
    MCCARTHY, James
    193 Weston Lane
    Bulkington
    CV12 9RX Bedworth
    Warwickshire
    Amministratore
    193 Weston Lane
    Bulkington
    CV12 9RX Bedworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish74209750001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Amministratore
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MCNAUGHT, William Wright
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    British52531510002
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish156912990001
    REICHERTER, Matthias Alexander
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomGerman138502740001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Amministratore
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    TAIYEB, Serajul Islam
    14 Swan Lane
    IG10 4QW Loughton
    Essex
    Amministratore
    14 Swan Lane
    IG10 4QW Loughton
    Essex
    British36414160002
    UNSWORTH, John Warburton
    17 Lower Road
    HP22 5XA Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    Amministratore
    17 Lower Road
    HP22 5XA Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    EnglandBritish99164650001

    TRAFFIC INFORMATION SERVICES (TIS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 13 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that leasehold property known as unit 3 quinton busines park quinton express way birmingham by way of fixed charge all fixed plant machinery trade fixtures and fittings all the income the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westlb Ag London Branch
    Transazioni
    • 13 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any contract between the company and the chargee
    Brevi particolari
    With full title guarantee subject to a first fixed charge to the chargee by way of second fixed charge held or to be held in the name of the chargee and the company designated "sos insurance account" and all sums standing to the credit of such account and any accrued interest.
    Persone aventi diritto
    • Secretary of State for the Environment Transport and the Regions
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contract between the company and the chargee
    Brevi particolari
    With full title guarantee to the chargee by way of first fixed charge the retention account held in the name the chargee and the company as the "charge rention account" and all sums standing to the credit of each such account and any accrued interest.
    Persone aventi diritto
    • Secretary of State for the Environment Transport and the Regions
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in accordance with the terms of the financing documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale London Branchas Security Trustee for the Secured Beneficiaries ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0