OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED

OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04017598
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MELONDRIFT LIMITED20 giu 200020 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Queen Anne Street London W1G 9EL a 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE in data 07 dic 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 nov 2015

    LRESSP

    Nomina di Mr Colin Barry Wagman come amministratore in data 17 nov 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 nov 2015

    Stato del capitale al 24 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Nomina di Mr James Anthony Piper come amministratore in data 31 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ivan Howard Ezekiel come segretario in data 28 gen 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Michael George Cohen come amministratore in data 31 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ivan Howard Ezekiel come amministratore in data 28 gen 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Claude Garnham come amministratore in data 28 gen 2015

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Alexander Wilson Lamont come amministratore in data 31 dic 2014

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Jonathan Goswell come amministratore in data 31 dic 2014

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 42 Wigmore Street London W1U 2RY a 40 Queen Anne Street London W1G 9EL in data 02 mar 2015

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2014

    Stato del capitale al 04 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 nov 2013

    Stato del capitale al 06 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2012 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant153509790001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    Uk
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    Uk
    United KingdomBritishDirector60475780003
    LAMONT, Alexander Wilson
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor 10
    Uk
    Amministratore
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor 10
    Uk
    EnglandBritishDirector158518680001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    Amministratore
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritishManaging Director, Real Estate Investment163685440001
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant189915990001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    BritishDirector56155670004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    BritishCompany Director35406400003
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector66502160002
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    Amministratore
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritishCompany Director76373440001
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector106868320001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director118467060001

    OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 23 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from omd property limited and/or the new owners to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Acquisito il 21 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The beneficial interest in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of 90 high holborn L.P. the legal estate in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of omd holborn nominee company limited and omd holborn second nominee company limited.
    Persone aventi diritto
    • Minerva Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Acquisito il 21 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The beneficial interest in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of 90 high holborn L.P. the legal estate in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of omd holborn nominee company limited and omd holborn second nominee company limited.
    Persone aventi diritto
    • Minerva PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Acquisito il 21 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The beneficial interest in the l/h property k/a 90 high holborn, london, the undertaking and all property and assets present and future of 90 high holborn L.P.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Acquisito il 21 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The legal estate in the l/h property k/a 90 high holborn, london, the undertaking and all property and assets present and future of omd holborn nominee company limited and omd holborn second nominee company limited.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 28 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Minerva Corporation PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 28 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Minerva PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 24 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee acting as trustee for the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the l/h property k/a 90 high holborn, london,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation of charge and confirmation
    Creato il 23 mar 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness or any of the present or future actual or contingent obligations or liabilities of the obligors to the beneficiaries under any finance document (all as defined)
    Brevi particolari
    The company charges to agent as trustee for the beneficiaries by way of first fixed charge its interest in any money at the date of the deed or at any time thereafter standing to the credit of the projected payment account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent")
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mezzanine debenture
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 10 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness or any of the present or future, actual or contingent obligations or liabilities of the borrower (as defined) to the chargee under any finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 10 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 10 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness or any of the present or future, actual or contingent obligations or liabilities of the obligors (as defined) to the beneficiaries (as defined) under any finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 10 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture made between the company and omd holborn limited acting for (1) themselves and (2) as general partners on behalf of 90 high holborn LP (the borrower) (in each capacity the "chargors" and each a "chargor") and omd holdings limited (the lender)
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 04 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent whether owed jointly severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the chargors or by some other person) of the chargors to the lender
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Omd Holdings Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 nov 2015Inizio della liquidazione
    07 mar 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0