QUADRIGA HOLDINGS LIMITED

QUADRIGA HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQUADRIGA HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04019893
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    16 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    16 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    3 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Forum 1 Station Road Theale Berkshire RG7 4RA a Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD in data 07 mar 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Seale Alonzo Moorer come persona con controllo significativo il 09 lug 2016

    2 paginePSC01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher John Maityard come amministratore in data 26 giu 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di James Gerard Naro come amministratore in data 07 mar 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2016

    Stato del capitale al 22 lug 2016

    • Capitale: GBP 75,724,023
    SH01

    Nomina di Mr Christopher John Maityard come amministratore in data 13 mag 2016

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 040198930008, creata il 18 dic 2015

    112 pagineMR01

    Memorandum e Statuto

    16 pagineMA

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    35 pagineAA

    Cessazione della carica di Isabelle Sarah Kirk come segretario in data 21 ago 2015

    1 pagineTM02

    Iscrizione dell'ipoteca 040198930007, creata il 07 ago 2015

    55 pagineMR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr James Gerard Naro come amministratore in data 09 lug 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORER, Seale Alonzo
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican199604390001
    AULT, Isabel Mary Katherine
    87 Shaftesbury Road
    SP2 0DU Wilton
    Jasmine Cottage
    Wiltshire
    United Kingdom
    Segretario
    87 Shaftesbury Road
    SP2 0DU Wilton
    Jasmine Cottage
    Wiltshire
    United Kingdom
    128525910001
    DALLISON, Adrian John
    41 Common Hill
    BA14 6EE Steeple Ashton
    Wiltshire
    Segretario
    41 Common Hill
    BA14 6EE Steeple Ashton
    Wiltshire
    British52541710002
    JENKINS, Elisabeth Anne
    50a Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    Segretario
    50a Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    British72837960002
    KIRK, Isabelle Sarah
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    United Kingdom
    199579500001
    MOHINDRA, Ravi Kumar
    12 Falcon House Gardens
    Woolton Hill
    RG20 9UQ Newbury
    Berkshire
    Segretario
    12 Falcon House Gardens
    Woolton Hill
    RG20 9UQ Newbury
    Berkshire
    British122688990001
    MORDECAI, Laura Rose
    Flat 15
    23 Chartfield Avenue
    SW15 6DX Putney
    London
    Segretario
    Flat 15
    23 Chartfield Avenue
    SW15 6DX Putney
    London
    British65797190002
    WATSON, David Andrew
    58 Shepherds Lane
    Caversham Heights
    RG4 7JL Reading
    Segretario
    58 Shepherds Lane
    Caversham Heights
    RG4 7JL Reading
    British52990930003
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    131429630001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Segretario nominato
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    ANDRADI, Benedict Pius Marilaan
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish82360580001
    AUSTIN, Terry Alan
    The Barn
    Handpost Farm Barkham
    RG41 4TN Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Barn
    Handpost Farm Barkham
    RG41 4TN Wokingham
    Berkshire
    British82652640001
    BARDEN-STYLIANOU, Stelios Stephen
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Amministratore
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    EnglandBritish125782940001
    BUDIE, Marcus Johanes Theodorus
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomDutch105980560001
    CRABB, Ian Denis
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish70017710003
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    FORBES, Alistair Robert Ballantyne
    Spring House
    Browns Lane Great Bedwyn
    SN8 3LR Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Spring House
    Browns Lane Great Bedwyn
    SN8 3LR Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish168893980001
    GALLAGHER, Patrick James
    Fulling Mill
    The Weir
    RG28 7RA Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Fulling Mill
    The Weir
    RG28 7RA Whitchurch
    Hampshire
    British77355310002
    HANDS, Guy
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    British2519120002
    HOWES, Lewis Verlie
    Gisburn
    50 Woodham Waye
    GU21 5SJ Woking
    Surrey
    Amministratore
    Gisburn
    50 Woodham Waye
    GU21 5SJ Woking
    Surrey
    EnglandBritish62776210004
    HULL, Jonathan
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish116761670001
    LEVY, Lionel Anthony
    29 Pangbourne Drive
    Stanmore
    HA7 4RA Middlesex
    Amministratore
    29 Pangbourne Drive
    Stanmore
    HA7 4RA Middlesex
    United KingdomBritish105270770001
    MAITYARD, Christopher John
    Station Rd
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Station Rd
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritish210342460001
    MARSH, Gary Neil
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Amministratore
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    EnglandBritish122518590001
    MILLER, Louise Ann
    Pound Cottages
    High Street
    RG8 9JH Streatley
    6
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Pound Cottages
    High Street
    RG8 9JH Streatley
    6
    Berkshire
    United Kingdom
    British127375160002
    NARO, James Gerard
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican199606110001
    NWANA, Hyacinth Sama, Dr
    19 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    19 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British53962580002
    PATEL, Harnish Natubhai
    High Pines
    Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    Amministratore
    High Pines
    Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    British90038150001
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Amministratore
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    EnglandBritish110080200001
    SUNDERLAND, Neil Vernon
    Zuercherstrasse 80a
    Uitikon
    8142 Switzerland
    Amministratore
    Zuercherstrasse 80a
    Uitikon
    8142 Switzerland
    Swiss44808550001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Amministratore
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    EnglandBritish,American106792270001
    TATARYN, Myron Anton
    The Leys
    The Street
    NR35 2BJ Topcroft
    Suffolk
    Amministratore
    The Leys
    The Street
    NR35 2BJ Topcroft
    Suffolk
    United KingdomBritish105980670001
    TAYLOR, Roger David
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Amministratore
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    United KingdomBritish73602910003
    TYRRELL, Patricia Valentine
    Le Bas Marais
    Na Lliers
    La Vendee 85370
    France
    Amministratore
    Le Bas Marais
    Na Lliers
    La Vendee 85370
    France
    British105980890001
    WAKE, Lorna
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Amministratore
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    United KingdomBritish210114660001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Seale Alonzo Moorer
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    09 lug 2016
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    No
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Exceptional Innovation B.V.
    Hoogoorddreef 15
    1101 Ba Amsterdam
    Amerika Building
    Netherlands
    06 apr 2016
    Hoogoorddreef 15
    1101 Ba Amsterdam
    Amerika Building
    Netherlands
    No
    Forma giuridicaPrivate Company With Limited Liability
    Paese di registrazioneNetherlands
    Autorità legaleDutch Company Law
    Luogo di registrazioneNetherlands
    Numero di registrazione855133697
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    QUADRIGA HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2015
    Consegnato il 23 dic 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Trust Company America
    Transazioni
    • 23 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 ago 2015
    Consegnato il 18 ago 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Trust Company Americas
    Transazioni
    • 18 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 dic 2013
    Consegnato il 06 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (Previously Known as Lloyds Tsb Bank PLC)
    Transazioni
    • 06 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 11 feb 2010
    Consegnato il 12 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security between, inter alia, the chargor and the security agent (as defined)(the "security document")
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 19 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys, debts and liabilities due, owing or incurred by the chargor to any finance party under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of Thefinance Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 19 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document between the chargors (as defined) and the security agent
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 19 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any finance party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,London,as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 19 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of pledge of registered shares between the pledgor the pledgee and the company (as defined) executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Creato il 14 mar 2001
    Consegnato il 28 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any and all of the present and future monetary obligations and liabilities of the pledgor to the pledgee (including the parallel debt) whether due and payable or not and whether contingent or not under or pursuant to the deed (the secured obligations)(as defined)
    Brevi particolari
    As security for the secured obligations the pledgor agrees to grant and grants to the pledgee the right of the pledge and the pledgee accepts the right of the pledge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC in Its Capacity as Security Agent (The "Pledgee")
    Transazioni
    • 28 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 set 2000
    Consegnato il 03 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors to any finance party under the finance documents or any hedging creditor under the hedging documents
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all shares and all related rights accruing to the shares and all interest in the shares all moneys standing to the credit of any account all book and other debts the goodwill uncalled capital and by way of floating charge all assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Finance Parties (Asdefined) (the Security Agent)
    Transazioni
    • 03 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    QUADRIGA HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 feb 2019Inizio dell'amministrazione
    17 feb 2021Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Praticante
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Christopher Purkiss
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Praticante
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0